Roger Anthony COOKE
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Roger |
Deuxième prénom | Anthony |
Nom de famille | COOKE |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 25 |
Total | 28 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVRON AEROSPACE GROUP LIMITED | 01 mars 2004 | Dissoute | Senior Vp And General Counsel | Administrateur | Sw Myrtle Street 97201 Portland 1910 Oregon United States | Usa | Usa | |
SPS TECH TRADING LIMITED | 01 mars 2004 | Dissoute | Senior Vp & General Counsel | Administrateur | Sw Myrtle Street 97201 Portland 1910 Oregon United States | Usa | Usa | |
HI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED | 01 mars 2004 | Dissoute | Senior Vp & General Counsel | Administrateur | Sw Myrtle Street 97201 Portland 1910 Oregon United States | Usa | Usa | |
PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED | 24 oct. 2008 | 26 sept. 2013 | Dissoute | Executive | Administrateur | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa |
TITANIUM MC LIMITED | 24 janv. 2013 | 01 juin 2013 | Dissoute | Svp & General Counsel | Administrateur | PO BOX 704 Witton Road B6 7UR Witton Birmingham | Usa | Usa |
TIMET UK (EXPORT) LIMITED | 24 janv. 2013 | 01 juin 2013 | Dissoute | Svp & General Counsel | Administrateur | PO BOX 704 Witton B6 7UR Birmingham | Usa | Usa |
PCC UK GLOBAL HOLDINGS LIMITED | 24 janv. 2013 | 01 juin 2013 | Active | Svp & General Counsel | Administrateur | PO BOX 704 Witton B6 7UR Birmingham West Midlands | Usa | Usa |
TIMET EUROPE LIMITED | 24 janv. 2013 | 01 juin 2013 | Active | Svp & General Counsel | Administrateur | PO BOX 704 Holford Drive Birmingham B6 7UR West Midlands | Usa | Usa |
TIMET UK LIMITED | 24 janv. 2013 | 01 juin 2013 | Active | Svp & General Counsel | Administrateur | P.O.Box 704 Witton B6 7UR Birmingham | Usa | Usa |
WYMAN-GORDON (LINCOLN) LIMITED | 21 nov. 2008 | 01 juin 2013 | Dissoute | Sr Vp & General Counsel | Administrateur | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa |
WYMAN-GORDON LIMITED | 21 nov. 2008 | 01 juin 2013 | Active | Sr Vp & General Counsel | Administrateur | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa |
AETC LIMITED | 20 nov. 2008 | 01 juin 2013 | Active | Sr Vp & General Counsel | Administrateur | Victoria Avenue Yeadon LS19 7AW Leeds West Yorkshire | Usa | Usa |
CALEDONIAN ALLOYS LIMITED | 13 nov. 2008 | 01 juin 2013 | Active | Sr. Vp & General Counsel | Administrateur | Wyman Gordon Complex Houstoun Road EH54 5BZ Livingston | Usa | Usa |
CALEDONIAN ALLOYS GROUP LIMITED | 13 nov. 2008 | 01 juin 2013 | Dissoute | Sr Vp & General Counsel | Administrateur | Wyman Gordon Complex Houstoun Road EH54 5BZ Livingston | Usa | Usa |
SPECIAL METALS WIGGIN LIMITED | 01 oct. 2008 | 01 juin 2013 | Active | Sr Vp & General Counsel | Administrateur | Holmer Road HR4 9SL Hereford Wiggin Works | Usa | Usa |
SPS TECHNOLOGIES LIMITED | 01 mars 2004 | 01 juin 2013 | Active | Senior Vp & General Counsel | Administrateur | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa |
CHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED | 01 mars 2004 | 01 juin 2013 | Dissoute | Senior Vp & General Counsel | Administrateur | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa |
SPS CHEVRON LIMITED | 01 mars 2004 | 01 juin 2013 | Dissoute | Senior Vp And General Counsel | Administrateur | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa |
SPS AEROSTRUCTURES LIMITED | 01 mars 2004 | 01 juin 2013 | Active | Senior Vp & General Counsel | Administrateur | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa |
WYMAN-GORDON (LINCOLN) LIMITED | 28 avr. 2000 | 01 juin 2013 | Dissoute | Sen Vp Gen Counsel | Secrétaire | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | |
SBP HOLDINGS LIMITED | 09 août 2011 | 03 mai 2013 | Active | General Counsel | Administrateur | Invincible Road GU14 7QU Farnborough 21 Hampshire United Kingdom | Usa | Usa |
TRIUMPH STRUCTURES INTERNATIONAL, LTD. | 09 août 2011 | 03 mai 2013 | Active | General Counsel | Administrateur | Invincible Road GU14 7QU Farnborough 21 Hampshire United Kingdom | Usa | Usa |
TRIUMPH AEROSPACE OPERATIONS UK, LTD. | 09 août 2011 | 03 mai 2013 | Active | Senior Vp & General Counsel | Administrateur | Invincible Road GU14 7QU Farnborough 21 Hampshire United Kingdom | Usa | Usa |
AIRDROME PARTS CO.,LIMITED | 30 sept. 2008 | 30 mars 2012 | Dissoute | Sr Vp And General Counsel | Administrateur | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa |
A F AEROSPACE LIMITED | 30 sept. 2008 | 30 mars 2012 | Dissoute | Sr Vp & General Counsel | Administrateur | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa |
CAMERON FORGED PRODUCTS LIMITED | 21 nov. 2008 | 22 nov. 2011 | Dissoute | Sr Vp & General Counsel | Administrateur | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa |
THE CALEY GROUP LIMITED | 13 nov. 2008 | 14 févr. 2011 | Dissoute | Sr Vp & General Consultant | Administrateur | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa |
AETC LIMITED | 22 mai 2001 | 01 déc. 2008 | Active | Vice President & Secretary | Secrétaire | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0