Philip Arthur Victor Selim OSMAN
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Philip |
Deuxième prénom | Arthur Victor Selim |
Nom de famille | OSMAN |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 2 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 62 |
Total | 67 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARKWOOD HALL CO-OPERATIVE ACADEMY TRUST | 12 déc. 2019 | Active | Retired | Administrateur | Beechenlea Lane BR8 8DR Swanley Parkwood Hall Cooperative Academy Kent England | England | British | |
UPPER TILEHOUSE LIMITED | 13 oct. 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | Wilbury Way SG4 0TW Hitchin Invision House Hertfordshire United Kingdom | England | British | |
GISTO LIMITED | 03 mars 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | Wilbury Way SG4 0TW Hitchin Invision House Hertfordshire | England | British | |
UP TECHNOLOGIES LTD | 17 févr. 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells Bush House Kent United Kingdom | England | British | |
LAWTAX LIMITED | 22 mars 2000 | Active | Solicitor | Administrateur | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent England | England | British | |
FULCRUM CARE LIMITED | 07 oct. 2019 | 31 mars 2024 | Active | Solicitor/Director | Administrateur | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent England | England | British |
SKYEASTOF LIMITED | 01 mars 2015 | 06 oct. 2016 | Active | Director | Administrateur | Wilbury Way SG4 0TW Hitchin Invision House Hertfordshire | England | British |
ROCKWILL WEALTH SOLUTIONS LIMITED | 04 avr. 2016 | 08 juin 2016 | Active | Director | Administrateur | Invision House Wilbury Way SG4 0TW Hitchin Rmcs Company Secretaries Limited Hertfordshire United Kingdom | England | British |
WOODEN SWORD LIMITED | 04 avr. 2016 | 08 juin 2016 | Active | Director | Administrateur | Invision House Wilbury Way SG4 0TW Hitchin Rmcs Company Secretaries Limited Hertfordshire United Kingdom | England | British |
LAND BREEZE LIMITED | 06 oct. 2015 | 08 juin 2016 | Active | Director | Administrateur | Wilbury Way SG4 0TW Hitchin Invision House Hertfordshire United Kingdom | England | British |
RIGHTWAY COMMODITIES LIMITED | 04 avr. 2016 | 08 juin 2016 | Dissoute | Director | Administrateur | Invision House Wilbury Way SG4 0TW Hitchin Rmcs Company Secretaries Limited Hertfordshire United Kingdom | England | British |
RAMNEX TRADE LIMITED | 03 juil. 2015 | 08 juin 2016 | Dissoute | Director | Administrateur | Invision House Wilbury Way SG4 0TW Hitchin Rmcs Company Secretaries Limited Hertfordshire United Kingdom | England | British |
SOFT SOFT APP LIMITED | 18 juil. 2014 | 05 mai 2016 | Dissoute | Director | Administrateur | Luke Street EC2A 4EE London 2 Victoria Chambers United Kingdom | England | British |
MIRAX MEDICAL SOLUTIONS LIMITED | 01 nov. 2014 | 30 sept. 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | Engel Park NW7 2HE London 21 England | England | British |
CREECHURCH HOLDINGS LIMITED | 20 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Active | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
TRENWICK UNDERWRITING LIMITED | 20 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Active | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
CANOPIUS CAPITAL SEVEN LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Active | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
CANOPIUS CAPITAL FOUR LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Active | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
TRENWICK UK HOLDINGS LIMITED | 11 juin 2009 | 16 juil. 2010 | Active | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
TRENWICK UK LIMITED | 11 juin 2009 | 16 juil. 2010 | Active | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
CANOPIUS HOLDINGS UK LIMITED | 02 juin 2009 | 16 juil. 2010 | Active | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED | 26 mai 2009 | 16 juil. 2010 | Active | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
CREECHURCH SERVICES LIMITED | 20 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
BOWMAN LOSS ADJUSTERS LIMITED | 09 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
GRACECHURCH UTG NO. 430 LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
GRACECHURCH UTG NO. 419 LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
GRACECHURCH UTG NO. 422 LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
GRACECHURCH UTG NO. 414 LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
GRACECHURCH UTG NO. 415 LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
GRACECHURCH UTG NO. 424 LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
GRACECHURCH UTG NO. 421 LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
GRACECHURCH UTG NO. 449 LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
GRACECHURCH UTG NO. 423 LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
GRACECHURCH UTG NO. 420 LIMITED | 01 juil. 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British | ||
GRACECHURCH UTG NO. 426 LIMITED | 11 juin 2009 | 16 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Bells Yew Green TN3 9AN Tunbridge Wells The Bush House Kent | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0