Philip James HOUNSLOW
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Philip |
Deuxième prénom | James |
Nom de famille | HOUNSLOW |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 2 |
Démissionné | 13 |
Total | 15 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEGANCE YACHTS LIMITED | 24 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British | |||
ANDRATX PROPERTIES LTD | 29 mai 2003 | Dissoute | Secrétaire | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British | |||
THE GEORGE CENTRE LTD | 07 sept. 1999 | 16 févr. 2016 | Liquidation | Secrétaire | Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Blythswood House Hampshire United Kingdom | British | ||
ADLAM MARINE LIMITED | 07 déc. 2006 | 12 oct. 2014 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | Carbery Manor Adlams Lane Sway SO41 6EG Lymington The Cottage Hampshire United Kingdom | British | |
ADLAM MARINE LIMITED | 23 août 2011 | 26 mars 2013 | Dissoute | Accountant | Administrateur | The Cottage, Carbery Manor Adlams Lane Sway SO41 6EG Lymington Hampshire | England | British |
ADLAM MARINE LIMITED | 07 déc. 2006 | 30 juin 2010 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Adlams Lane Sway SO41 6EG Lymington The Cottage, Carbery Manor Hampshire United Kingdom | England | British |
THE GEORGE CENTRE LTD | 23 mars 1999 | 01 juin 2010 | Liquidation | Financial Director | Administrateur | Adlams Lane Sway SO41 6EG Lymington The Cottage, Carbery Manor Hampshire United Kingdom | England | British |
WILLIAMS JET TENDERS LIMITED | 30 mars 2005 | 01 juin 2008 | Active | Finance Director | Administrateur | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | England | British |
WILLIAMS JET TENDERS LIMITED | 30 mars 2005 | 01 janv. 2008 | Active | Finance Director | Secrétaire | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British | |
ALMANSA CONSTRUCTION LIMITED | 09 juil. 1996 | 23 oct. 2003 | Dissoute | Financial Director | Administrateur | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | England | British |
ALMANSA CONSTRUCTION LIMITED | 09 juil. 1996 | 31 mai 2003 | Dissoute | Financial Director | Secrétaire | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British | |
PARKER BATH LIMITED | 31 juil. 1996 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | England | British | |
PARKER BATH LIMITED | 31 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British | |||
THE GEORGE CENTRE LTD | 06 avr. 1994 | 11 janv. 1995 | Liquidation | Financial Director | Administrateur | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | England | British |
THE GEORGE CENTRE LTD | 06 avr. 1994 | 11 janv. 1995 | Liquidation | Financial Director | Secrétaire | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0