• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Ian Anthony ELLIS

    Personne physique

    TitreMr
    PrénomIan
    Deuxième prénomAnthony
    Nom de familleELLIS
    Date de naissance
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif1
    Inactif0
    Démissionné39
    Total40

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    BOPARAN HOLDINGS LIMITED28 mai 2020ActiveDirectorAdministrateur
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    EnglandBritish
    ENACTUS UK15 juil. 202313 nov. 2024ActiveCompany DirectorAdministrateur
    Wadkins Way
    Bushby
    LE7 9NA Leicester
    7
    EnglandBritish
    SOTERIA INSURANCE LIMITED25 juin 202002 déc. 2020ActiveDirectorAdministrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ANGEL SQUARE INVESTMENTS LIMITED02 nov. 201801 mai 2019Converti / FerméChief Financial OfficerAdministrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    EnglandBritish
    WHSL REALISATIONS LIMITED05 mars 201407 sept. 2015En administrationAccountantAdministrateur
    Roebuck Way
    Manton Wood
    S80 3EG Worksop
    Jk House
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritish
    WILKO BRAND PROTECTION LIMITED18 oct. 201107 sept. 2015DissouteFinance DirectorAdministrateur
    Roebuck Way
    Manton Wood
    S80 3EG Worksop
    J.K. House,
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritish
    WILKINSON RETAIL LIMITED18 oct. 201107 sept. 2015DissouteAccountantAdministrateur
    Roebuck Way
    Manton Wood
    S80 3EG Worksop
    J.K. House
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritish
    WILKO PROPERTY LIMITED19 mai 201107 sept. 2015DissouteAccountantAdministrateur
    Roebuck Way
    Manton Wood
    S80 3EG Worksop
    J.K. House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    WILKINSON PROPERTY LIMITED19 mai 201107 sept. 2015DissouteAccountantAdministrateur
    Roebuck Way
    Manton Wood
    S80 3EG Worksop
    J.K.House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    WILKO STORES LIMITED04 mai 201107 sept. 2015DissouteAccountantAdministrateur
    Roebuck Way
    S80 3EG Worksop
    J K House
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritish
    WILKINSON STORES LIMITED04 mai 201107 sept. 2015DissouteAccountantAdministrateur
    Roebuck Way
    S80 3EG Worksop
    J K House
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritish
    WL REALISATIONS (2023) LIMITED06 mai 200807 sept. 2015LiquidationAccountantAdministrateur
    Roebuck Way
    Manton Wood
    S80 3EG Worksop
    Jk House
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritish
    COOLSILK PROPERTY & INVESTMENT LIMITED03 févr. 201431 mars 2014ActiveAccountantAdministrateur
    PO BOX 20
    Roebuck Way Manton Wood
    S80 3YY Worksop
    Jk House
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritish
    F.W. FARNSWORTH LIMITED08 mars 200519 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    NORTHERN FOODS GROCERY GROUP LIMITED26 nov. 200419 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    CONVENIENCE FOODS LIMITED26 nov. 200419 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    TODAYULTRA LIMITED05 mai 200019 mai 2006DissouteGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    EDEN VALE FOOD INGREDIENTS LIMITED05 mai 200019 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    CENTURY WAY (WILTSHIRE) PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED05 mai 200019 mai 2006DissouteGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    SWISS MILK PRODUCTS LIMITED05 mai 200019 mai 2006DissouteGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    NORCAY LIMITED05 mai 200019 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    NORTHERN FOODS AMERICAN HOLDINGS LIMITED05 mai 200019 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    FARNSWORTH INVESTMENTS LIMITED05 mai 200019 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    BEVERLEY HOUSE (9000) LIMITED05 mai 200019 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    BEVERLEY HOUSE INVESTMENTS LIMITED05 mai 200019 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    HULCAY LIMITED05 mai 200019 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    BUXTED CHICKEN LIMITED05 mai 200019 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    DREAMPHOTO LIMITED05 mai 200019 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    RAWMARSH FOODS LIMITED05 mai 200019 mai 2006LiquidationGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    DREAMPLAYER LIMITED05 mai 200019 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    BEVERLEY HOUSE FOODS (BOYLE) LIMITED21 févr. 200512 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    POLDY'S FRESH FOODS LIMITED21 févr. 200512 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    BEVERLEY HOUSE FOOD GROUP LIMITED21 févr. 200512 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    BEVERLEY HOUSE GROUP SERVICES LIMITED21 févr. 200512 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish
    BEVERLEY HOUSE FOODS PORTUMNA LIMITED21 févr. 200512 mai 2006ActiveGroup Finance ExecutiveAdministrateur
    25 Peacock Close
    Killamarsh
    S21 1BF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0