Antony Gerard EBEL
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Antony |
| Deuxième prénom | Gerard |
| Nom de famille | EBEL |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 15 |
| Inactif | 7 |
| Démissionné | 26 |
| Total | 48 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPLICIT GROUP LIMITED | 28 avr. 2022 | Active | Administrateur | The Square 2-12 Commercial Road BH2 5LP Bournemouth 1st Floor At Bobby's Dorset England | England | British | ||
| IPLICIT LIMITED | 28 avr. 2022 | Active | Administrateur | The Square 2-12 Commercial Road BH2 5LP Bournemouth 1st Floor At Bobby's Dorset England | England | British | ||
| MEMORIAL MANAGEMENT LIMITED | 17 déc. 2012 | Dissoute | Administrateur | Hunts Pond Road PO14 4PJ Fareham 235 Hampshire United Kingdom | England | British | ||
| KEMNAL INVESTMENTS LIMITED | 21 juin 2012 | Dissoute | Administrateur | Hunts Pond Road PO14 4PJ Fareham 235 United Kingdom | England | British | ||
| SMU INVESTMENTS LTD | 11 avr. 2011 | Dissoute | Administrateur | The Close SP1 2EL Salisbury 56a Wilts United Kingdom | England | British | ||
| DHPD LIMITED | 31 mars 2011 | Dissoute | Administrateur | Hunts Pond Road PO14 4PJ Fareham 235a Hampshire England | England | British | ||
| PROPERTY MANAGEMENT SERVICES UK LIMITED | 04 déc. 2002 | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | |||
| VALLEYWEST LIMITED | 11 sept. 2001 | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | |||
| SWITCHVIEW DEVELOPMENTS LIMITED | 11 sept. 2001 | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | |||
| MANOR GARDENS INVESTMENTS LIMITED | 23 août 2001 | Active | Administrateur | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | England | British | ||
| FORMNEXT LIMITED | 15 mai 2001 | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | |||
| LEWIS ENTERTAINMENTS LIMITED | 16 janv. 2001 | Active | Administrateur | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | England | British | ||
| ENTERTAINMENT CORPORATION SPONSORSHIP & LICENSING COMPANY LIMITED | 29 sept. 1999 | Dissoute | Administrateur | Princes Gate SW7 1QJ London 5 | England | British | ||
| PRIMEPOINT PROPERTIES LTD | 29 mars 1999 | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | |||
| HAMILTONS MANAGEMENT SERVICES LTD. | 19 oct. 1998 | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | |||
| ALEXANDRA LODGE (BOURNEMOUTH) LIMITED | 23 sept. 1998 | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | |||
| NAPIER MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 24 août 1995 | Active | Administrateur | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | England | British | ||
| ROAD RUNNER INTERNATIONAL LIMITED | 16 nov. 1993 | Dissoute | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | |||
| WATLINGTON SECURITIES LIMITED | 18 oct. 1993 | Dissoute | Administrateur | Princes Gate SW7 1QJ London 5 | England | British | ||
| HIGHTOWN SECURITIES LIMITED | Active | Administrateur | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | England | British | |||
| HTM (UK) LIMITED | 26 févr. 1992 | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | |||
| MICRODISC LIMITED | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | ||||
| LIVING NATURE LIMITED | 25 oct. 2001 | 30 juin 2025 | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | ||
| UNDERWOODS INVESTMENTS LIMITED | 31 déc. 2013 | 02 juin 2025 | Active | Administrateur | 56a The Close Salisbury SP1 2EL | England | British | |
| GREENACRES KEMNAL PARK LIMITED | 18 juin 2012 | 18 mai 2018 | Active | Administrateur | Floor 17 Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 5th United Kingdom | England | British | |
| GRESHAM HOUSE LIMITED | 14 juin 2006 | 01 déc. 2014 | Active | Administrateur | Hunts Pond Road PO14 4PJ Fareham 235 Hampshire England | England | British | |
| SECURITY CHANGE LIMITED | 01 nov. 2005 | 01 déc. 2014 | Active | Administrateur | 17 Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 5th Floor England | England | British | |
| UNDERWOODS INVESTMENTS LIMITED | 09 nov. 1998 | 31 déc. 2013 | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | ||
| THE M CORPORATION LIMITED | 06 janv. 2000 | 21 juil. 2011 | Dissoute | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | ||
| SPORTS INTERNATIONAL LIMITED | 01 oct. 2009 | 23 mai 2011 | Dissoute | Administrateur | Old Gas Works The Cranewell Building 2 Michael Road SW6 2AD London Unit Cw 17 United Kingdom | England | British | |
| BRITISH GAS SOLAR LIMITED | 21 févr. 2003 | 25 sept. 2008 | Dissoute | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | ||
| AZZURRI TECHNOLOGY LIMITED | 10 sept. 1997 | 31 mars 2008 | Dissoute | Administrateur | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | England | British | |
| GRESHAM HOUSE LIMITED | 13 juin 2006 | Active | Administrateur | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | England | British | ||
| RADCLIFFE COURT FREEHOLD LIMITED | 28 nov. 2002 | 01 avr. 2006 | Active | Secrétaire | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | British | ||
| SECURITY CHANGE LIMITED | 31 oct. 2005 | Active | Administrateur | The Annexe 56a The Close SP1 2EL Salisbury Wiltshire | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0