WILKINSON ACCOUNTING SOLUTIONS LTD
Dirigeant de société
Nom | WILKINSON ACCOUNTING SOLUTIONS LTD |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 8 |
Inactif | 9 |
Démissionné | 39 |
Total | 56 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
SANICO LIMITED | 22 déc. 2021 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom | |
RAASHI INVESTMENTS LIMITED | 17 nov. 2021 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom | |
CHEMEX SERVICES LIMITED | 18 juin 2021 | Dissoute | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom | |
SATARA SOUND LIMITED | 10 mars 2021 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom | |
SRIUCHE LIMITED | 18 déc. 2020 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom | |
ANKI MEDICAL CONSULTANTS LIMITED | 17 mai 2019 | Dissoute | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom | |
SRISAN PRACTICE LIMITED | 06 déc. 2016 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom | |
KHG ARTISANS LIMITED | 31 janv. 2013 | Dissoute | Secrétaire | Phillips Court Water Street PE9 2EE Stamford 36 Lincs United Kingdom | |
MSL FLOORING & INTERIORS LIMITED | 22 janv. 2013 | Dissoute | Secrétaire | Phillips Court Water Street PE9 2EE Stamford 36 Lincs United Kingdom | |
ZAHNKRAFFT LIMITED | 11 oct. 2012 | Active | Secrétaire | Second Floor, East Wing St. Johns Street PE1 5DD Peterborough Stuart House Cambs England | |
LARKSPUR PRACTICE LIMITED | 30 sept. 2011 | Active | Secrétaire | Second Floor East Wing St John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House England | |
AWSD LIMITED | 01 sept. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Tesla Court Innovation Way PE2 6FL Lynch Wood 26 Peterborough United Kingdom | |
R.N. HARTZENBERG LIMITED | 02 févr. 2009 | Active | Secrétaire | 2nd Floor, East Wing St John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House Cambs United Kingdom | |
MARTYN SKINNER AND ASSOCIATES LIMITED | 21 mai 2008 | Dissoute | Secrétaire | Tesla Court Innovation Way, Lynch Wood PE2 6FL Peterborough 26 Cambridgeshire | |
BREEZBON LTD | 01 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Tesla Court, Innovation Way Lynch Wood PE2 6FL Peterborough 26 United Kingdom | |
MFA INVESTMENTS LIMITED | 22 janv. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Thurston House, 80 Lincoln Road PE1 2SN Peterborough | |
AMETHYST CRYSTALS LIMITED | 09 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Tesla Court, Innovation Way Lynch Wood PE2 6FL Peterborough 26 United Kingdom | |
AIMALOHI LIMITED | 11 août 2021 | 14 août 2024 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom |
SERVISDENT LIMITED | 26 juil. 2017 | 30 juil. 2024 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom |
C Y C PRACTICE LTD | 21 juil. 2022 | 29 juil. 2024 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom |
VVV INVESTMENT LIMITED | 11 juil. 2012 | 25 juil. 2024 | Active | Secrétaire | Second Floor East Wing St John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House England |
BINTA-ADUNOLA LIMITED | 17 mai 2019 | 17 mai 2024 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom |
WMCD LIMITED | 30 janv. 2013 | 23 avr. 2024 | Active | Secrétaire | Phillips Court Water Street PE9 2EE Stamford 36 Lincs United Kingdom |
WECARE MEDICAL SURGERY LIMITED | 03 mars 2022 | 28 févr. 2024 | Dissoute | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom |
SION LEWIS LIMITED | 31 août 2011 | 20 févr. 2024 | Active | Secrétaire | 2nd Floor East Wing St Johns Street PE1 5DD Peterborough Stuart House England |
IMPLANT & AESTHETIC ACADEMY UK LIMITED | 17 nov. 2022 | 22 janv. 2024 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom |
ENIDENT LIMITED | 22 janv. 2013 | 22 janv. 2024 | Active | Secrétaire | Phillips Court Water Street PE9 2EE Stamford 36 Lincs United Kingdom |
B KWIC LIMITED | 03 sept. 2013 | 10 janv. 2024 | Active | Secrétaire | Phillips Court Water Street PE9 2EE Stamford 36 Lincs United Kingdom |
BEWL LIMITED | 16 juil. 2013 | 10 janv. 2024 | Active | Secrétaire | Phillips Court Water Street PE9 2EE Stamford 36 Lincs United Kingdom |
R T W SERVICES LIMITED | 09 déc. 2020 | 03 janv. 2024 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom |
WECARE SURGERY LIMITED | 14 août 2019 | 03 janv. 2024 | Active | Secrétaire | East Wing, St. John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House, Second Floor United Kingdom |
DEVON PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 18 juin 2007 | 12 oct. 2023 | Active | Secrétaire | Phillips Court Water Street PE2 6FL Stamford 36 Lincs United Kingdom |
TOP YARD RENTALS LIMITED | 30 oct. 2013 | 05 juin 2023 | Active | Secrétaire | Second Floor East Wing, St John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House United Kingdom |
LEES MEDICAL SERVICES LIMITED | 10 sept. 2018 | 29 avr. 2019 | Active | Secrétaire | 2nd Floor East Wing St. Johns Street PE1 5DD Peterborough Stuart House England |
FABIP LIMITED | 25 sept. 2012 | 09 avr. 2019 | Active | Secrétaire | 2nd Floor East Wing St John's Street PE1 5DD Peterborough Stuart House England |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0