Michael Alan SELF
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Michael |
| Deuxième prénom | Alan |
| Nom de famille | SELF |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 5 |
| Inactif | 4 |
| Démissionné | 6 |
| Total | 15 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI 4 SERVICE LIMITED | 09 janv. 2023 | Active | Administrateur | The Avenue S18 2LR Dronfield 7 England | England | British | ||
| TEAM 1101 LIMITED | 10 mars 2022 | Active | Administrateur | 203 Ecclesall Road S11 8HW Sheffield Wards Court United Kingdom | England | British | ||
| ALBION BUSINESS SOLUTIONS LTD | 22 déc. 2017 | Active | Administrateur | 1 Hartley Street S2 3AQ Sheffield Sum Studios England | England | British | ||
| MCI 4 BUSINESS LTD | 09 déc. 2017 | Dissoute | Director | Administrateur | Savile Street S4 7UD Sheffield Albion House United Kingdom | England | British | |
| TELWYN LIMITED | 03 oct. 2013 | Active | Administrateur | The Avenue S18 2LR Dronfield 7 Derbyshire England | England | British | ||
| MCI SOFTEK LIMITED | 29 mars 2011 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Savile Street S4 7UD Sheffield Albion House England | England | British | |
| 1101 LIMITED | 26 janv. 2009 | Active | Administrateur | 1 Hartley Street S2 3AQ Sheffield Sum House England | England | British | ||
| MCI DIVENTI LIMITED | 25 mai 2006 | Dissoute | Company Director | Administrateur | C/O A.M. Insolvency Limited Carlton Road S81 7QF Worksop Enterprise House Notts | England | British | |
| DIVENTI LIMITED | 27 oct. 2003 | Dissoute | Director | Administrateur | Savile Street S4 7UD Sheffield Albion House South Yorkshire | England | British | |
| ASPIRE COMMUNITY ENTERPRISE (SHEFFIELD) LIMITED | 26 juil. 2022 | 26 oct. 2023 | Active | Retired | Administrateur | Knutton Road Parson Cross S5 9NU Sheffield 11 Soar Works South Yorkshire | England | British |
| WINN HILL 14 LIMITED | 10 juil. 2019 | 26 févr. 2021 | Active | Director | Administrateur | 1 Hartley Street S2 3AQ Sheffield Sum House England | England | British |
| MCI INTERNATIONAL LIMITED | 31 janv. 2009 | 08 sept. 2018 | Active | Sales | Administrateur | Savile Street S4 7UD Sheffield Albion House South Yorkshire | England | British |
| THE ROCKINGHAM PARTNERSHIP LLP | 09 oct. 2013 | 31 mars 2014 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | The South West Centre Troutbeck Road S7 2QA Sheffield Unit 10 England | England | ||
| MCI DIVENTI LIMITED | 25 mai 2006 | 22 juin 2010 | Dissoute | Secrétaire | 7 The Avenue S18 2LR Dronfield | British | ||
| PERFEQ LIMITED | 17 déc. 2002 | 22 juin 2010 | Active | Secrétaire | 7 The Avenue S18 2LR Dronfield | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0