Craig Thomas WHYTE
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Craig |
Deuxième prénom | Thomas |
Nom de famille | WHYTE |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 2 |
Démissionné | 16 |
Total | 18 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM DISCOUNTS PLC | 10 nov. 2011 | Dissoute | Director | Administrateur | Floor Aldermary House 10-15 Queen Street EC4N 1TX London 7th United Kingdom | Scotland | British | |
CAIRNWELL INVESTMENTS LIMITED | 30 juin 2009 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Castle Grant Estate PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British | |
LITIGATION CAPITAL LIMITED | 12 mars 2013 | 29 août 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Skylines Village Limeharbour E14 9TS London 48 England | Scotland | British |
MEDIA LITIGATION LIMITED | 12 mars 2013 | 29 août 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Skylines Village Limeharbour E14 9TS London 48 England | Scotland | British |
LAW CAPITAL LIMITED | 12 mars 2013 | 29 août 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Skylines Village Limeharbour E14 9TS London 48 England | Scotland | British |
LAW FINANCIAL LIMITED | 12 mars 2013 | 11 août 2014 | Active | Director | Administrateur | Skylines Village Limeharbour E14 9TS London 48 England | Scotland | British |
THE RANGERS FC GROUP LIMITED | 11 févr. 2011 | 11 avr. 2014 | Active | Director | Administrateur | Bedford Row WC1R 4DF London 4 | Scotland | British |
RFC 2012 P.L.C. | 06 mai 2011 | 01 juin 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Row WC1R 4DF London 4 England | Scotland | British |
SEVCO 5088 LIMITED | 09 mai 2012 | 09 mai 2012 | Active | Company Director | Administrateur | Grantown-On-Spey PH26 3PS Morayshire Castle Grant Scotland | Scotland | British |
SEVCO 5088 LIMITED | 09 mai 2012 | 09 mai 2012 | Active | Company Director | Administrateur | Castle Grant PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire Scotland | Scotland | British |
MERCHANT STRATEGIC RENEWAL PLC | 30 sept. 2010 | 17 févr. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Aldermary House 15 Queen Street EC4N 1TX London 7th Floor United Kingdom | Scotland | British |
MERCHANT CORPORATE RECOVERY PLC | 30 juin 2009 | 17 févr. 2012 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Castle Grant Estate PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British |
MERCHANT HOUSE FINANCIAL SERVICES LIMITED | 20 juil. 2009 | 16 déc. 2010 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Castle Grant Estate PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British |
ZEMFILL PLC | 31 août 2010 | 01 sept. 2010 | Dissoute | Director | Administrateur | Aldermary House 15 Queen Street EC4N 1TX London 7th Floor United Kingdom | Scotland | British |
MERCHANT INTERACTIVE LTD | 11 sept. 2009 | 30 avr. 2010 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Castle Grant Estate PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British |
LM LOGISTICS GROUP LTD | 16 nov. 2009 | 04 mars 2010 | Liquidation | Company Director | Administrateur | Aldermary House 10-15 Queen Street EC4N 1TX London 7th Floor United Kingdom | Scotland | British |
MERCHANT TURNAROUND PLC | 05 janv. 2010 | 01 févr. 2010 | Liquidation | Director | Administrateur | PH263PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British |
COUNTRYLINER GROUP LTD | 04 août 2009 | 14 janv. 2010 | Dissoute | Director | Administrateur | Castle Grant Estate PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0