Nigel Kenneth CAYZER
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Nigel |
| Deuxième prénom | Kenneth |
| Nom de famille | CAYZER |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 2 |
| Inactif | 23 |
| Démissionné | 16 |
| Total | 41 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY ATTIRE LIMITED | 11 déc. 2019 | Dissoute | Administrateur | Stonecross Business Park, Stone Cross Lane North Lowton WA3 2SH Warrington Suite 3b, Stone Cross Place England | England | British | ||
| COUNTRY ATTIRE HOLDINGS LIMITED | 11 déc. 2019 | Dissoute | Administrateur | Stonecross Business Park, Stone Cross Lane North Lowton WA3 2SH Warrington Suite 3b, Stone Cross Place England | England | British | ||
| WHEELS WINGS & WATER LIMITED | 11 déc. 2019 | Dissoute | Administrateur | Stonecross Business Park, Stone Cross Lane North Lowton WA3 2SH Warrington Suite 3b, Stone Cross Place England | England | British | ||
| SURFDOME SHOP LIMITED | 11 déc. 2019 | Dissoute | Administrateur | Stone Cross Lane North Lowton WA3 2SH Warrington Suite 3b Stone Cross Place England | England | British | ||
| THE PRIORY MENSWEAR LTD | 11 déc. 2019 | Dissoute | Administrateur | Stonecross Business Park, Stone Cross Lane North Lowton WA3 2SH Warrington Suite 3b Stone Cross Place England | England | British | ||
| INTERNET FUSION LIMITED | 31 mars 2017 | Dissoute | Administrateur | Stone Cross Business Park Lowton WA3 2SH Warrington Suite 3b Stone Cross Place Greater Manchester England | England | British | ||
| NEWTYLE TRADING COMPANY LIMITED | 29 mars 2017 | Dissoute | Administrateur | Cannon Street EC4N 6EU London 2nd Floor 110 | England | British | ||
| INTERNET FUSION GROUP LIMITED | 21 sept. 2016 | Dissoute | Administrateur | c/o Jackson Stephen Llp Yew Tree Way Golborne WA3 3JD Warrington James House, Stonecross Business Park England | England | British | ||
| NEWTYLE DEVELOPMENTS LIMITED | 10 sept. 2015 | Dissoute | Administrateur | Chelsea Crescent Chelsea Harbour SW10 0XB London 44 England | England | British | ||
| DERBY HOUSE STABLING LIMITED | 25 avr. 2014 | Dissoute | Administrateur | Yew Tree Way Stonecross Business Park WA3 3JD Warrington James House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| DERBY HOUSE SADDLERY LIMITED | 25 avr. 2014 | Dissoute | Administrateur | Yew Tree Way Stonecross Business Park WA3 3JD Warrington James House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| NEWTYLE PROPERTY TWO LLP | 18 juin 2010 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Lundie DD2 5PA Dundee Thriepley House Angus | United Kingdom | |||
| KINPURNIE ONE LLP | 18 juin 2010 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Lundie DD2 5PA Dundee Thriepley House Angus | United Kingdom | |||
| NEWTYLE PROPERTY ONE LLP | 18 juin 2010 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Lundie DD2 5PA Dundee Thriepley House Angus | United Kingdom | |||
| KINPURNIE TWO LLP | 18 juin 2010 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Lundie DD2 5PA Dundee Thriepley House Angus | United Kingdom | |||
| THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (OXFORD) | 30 nov. 2006 | Dissoute | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | ||
| THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (LANARKSHIRE) | 30 nov. 2006 | Dissoute | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | ||
| THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (FIFE) | 02 déc. 2004 | Dissoute | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | ||
| THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (HIGHLANDS) | 02 déc. 2004 | Dissoute | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | ||
| DERBY HOUSE RETAIL LIMITED | 16 août 2002 | Dissoute | Administrateur | Chelsea Crescent Chelsea Harbour SW10 0XB London 44 England | England | British | ||
| DERBY HOUSE LIMITED | 02 avr. 2002 | Dissoute | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | ||
| 02099602 LIMITED | 02 avr. 2002 | Dissoute | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | ||
| 04404284 LIMITED | 02 avr. 2002 | Dissoute | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | ||
| NEWTYLE QUARRY COMPANY LIMITED | 30 avr. 1999 | Active | Administrateur | Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh Floor 3, 1-4 Scotland | Switzerland | British | ||
| MILTON(PETERBOROUGH)ESTATES COMPANY, | Active | Administrateur | Chelsea Harbour SW10 0XB London 44 Chelsea Crescent England | England | British | |||
| ABERDEEN ASIA FOCUS PLC | 28 sept. 1995 | 30 nov. 2022 | Active | Administrateur | Bishopsgate EC2M 4AG London 280 England | Switzerland | British | |
| THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (GLASGOW) | 04 nov. 2004 | 21 janv. 2014 | Active | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | |
| THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST | 16 janv. 2004 | 21 janv. 2014 | Active | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | |
| THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (DUNDEE) | 06 déc. 2000 | 21 janv. 2014 | Active | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | |
| MAGGIE'S TRADING LIMITED | 30 nov. 2006 | 25 janv. 2013 | Active | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | |
| BALTIMORE CAPITAL PLC | 31 juil. 2006 | 17 févr. 2011 | Dissoute | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | |
| CVS (UK) LIMITED | 13 août 1999 | 01 déc. 2005 | Active | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | |
| CALEDONIA INVESTMENTS PLC | 27 nov. 2001 | Active | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | ||
| HIGHWOOD FARMS LIMITED | 30 mai 1997 | 26 sept. 2001 | Active | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British | |
| ORIEL GROUP LIMITED | 16 mai 2001 | Dissoute | Administrateur | Thriepley House Lundie DD2 5PA Dundee | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0