Martin Howard STONE
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Martin |
Deuxième prénom | Howard |
Nom de famille | STONE |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 7 |
Inactif | 19 |
Démissionné | 42 |
Total | 68 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMFIN LLP | 14 nov. 2023 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Hillside House, 1 The Drive WD7 7FG Radlett Unit 12 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | |||
KLICK CONSULTING LIMITED | 05 avr. 2021 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Hillside House 1 The Drive WD7 7FG Radlett Unit 12 Hertfordshire England | England | British | |
CANDOR CAPITAL LIMITED | 11 août 2020 | Dissoute | Financial Consultant | Administrateur | Portland Street M1 3BE Manchester C/O Ams Accountants Corporate, 2nd Floor, 9 England | England | British | |
HARROWSIDE CONTRACTS LIMITED | 19 déc. 2017 | Active | Finance | Administrateur | 52 Coolhurst Road Crouch End N8 8EU London Unit 1 United Kingdom | England | British | |
THE LOST PENSION HELPLINE LTD | 19 déc. 2017 | Dissoute | Finance | Administrateur | 52 Coolhurst Road Crouch End N8 8EU London Unit 1 United Kingdom | England | British | |
PALATINE SERVICES LIMITED | 24 mars 2017 | Active | Company Director | Administrateur | Hillside House 1 The Drive WD7 7FG Radlett Unit 12 Hertfordshire England | England | British | |
WEXWOOD BUILDERS LIMITED | 01 mars 2016 | Active | Accountant | Administrateur | Spring Villa Road HA8 7EB Edgware 5 England | England | British | |
LEITH CARE LIMITED | 11 juin 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | The Broadway Mill Hill NW7 3TD London Athene House, 86 United Kingdom | England | British Virgin Islander | |
AFFINITY ANON LIMITED | 09 janv. 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | The Broadway Mill Hill NW7 3TD London Athene House, 86 United Kingdom | England | British Virgin Islander | |
AFFINITY HOUSING LIMITED | 29 juil. 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | 86 The Broadway NW7 3TD London Athene House England | England | British Virgin Islander | |
JEMSTONE PROPERTIES LIMITED | 30 nov. 2011 | Active | Accountant | Administrateur | Spring Villa Road HA8 7EB Edgware 5 England | England | British | |
JEMSTONE FINANCIAL LIMITED | 31 août 2008 | Active | Director | Administrateur | 1 The Drive WD7 7FG Radlett Flat 12 England | United Kingdom | British | |
ASSESSMENT ONLINE LIMITED | 30 août 2008 | Dissoute | Director | Administrateur | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | England | British Virgin Islander | |
BINSTOCK INVESTMENTS LIMITED | 26 mars 2008 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Armitage Road NW11 8RQ London Olympia House | England | British Virgin Islander | |
SUGAR LESS CONFECTIONERY LIMITED | 26 févr. 2007 | Dissoute | Director | Administrateur | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | England | British Virgin Islander | |
SUGAR LESS CONFECTIONERY LIMITED | 26 févr. 2007 | Dissoute | Director | Secrétaire | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | British Virgin Islander | ||
THEOBALDS CORPORATE FINANCE LLP | 02 nov. 2006 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | 33 Lawrence Gardens NW7 4JU Mill Hill | England | |||
ROVIRA PERSONNEL LIMITED | 11 janv. 2006 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | England | British Virgin Islander | |
SARAH HARVEY (LEAMINGTON SPA) LIMITED | 11 janv. 2006 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | England | British Virgin Islander | |
ANIMUS LIMITED | 10 févr. 2003 | Active | Financial Consultant | Administrateur | Hillside House 1 The Drive WD7 7FG Radlett Unit 12 Hertfordshire England | England | British | |
PBT LIMITED | 14 août 2002 | Dissoute | Secrétaire | 3 Arlington Green Mill Hill NW7 1GW London | British | |||
COOPER PBN LIMITED | 10 avr. 2002 | Dissoute | Director | Administrateur | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | England | British Virgin Islander | |
ESSENTIALLY LITE LIMITED | 01 mars 2002 | Dissoute | Director | Administrateur | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | England | British Virgin Islander | |
BOWMAKER SHARPE LIMITED | 22 oct. 2001 | Dissoute | Financial Consultant | Administrateur | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | England | British Virgin Islander | |
WEXWOOD BUILDERS LIMITED | 27 juin 2001 | Active | Secrétaire | Spring Villa Road HA8 7EB Edgware 5 England | British | |||
SHELANA (2000) LIMITED | 30 mai 2000 | Dissoute | Secrétaire | Unit 1, 52 Coolhurst Road Crouch End N8 8EU London 52 England | British | |||
ATHENE NEW BUILD LIMITED | 05 sept. 2023 | 05 sept. 2023 | Active | Director | Administrateur | Stirling Way WD6 2FX Borehamwood 1st Floor, Spitalfields House Herts England | United Kingdom | British |
KINGSBURY INVESTMENT & DEVELOPMENT GROUP LTD | 23 mars 2022 | 05 sept. 2023 | Active | Company Director | Administrateur | Stirling Way WD6 2FX Borehamwood 1st Floor, Spitalfields House England | England | British |
ATHENE BUSINESS CONSULTANTS LIMITED | 01 août 2016 | 09 janv. 2017 | Dissoute | Director | Administrateur | The Broadway Mill Hill NW7 3TD London Athene House, 86 United Kingdom | England | British Virgin Islander |
SNOWMAN LIMITED | 22 oct. 2002 | 20 nov. 2014 | Active | Secrétaire | Aston House Cornwall Avenue N3 1LF London | British Virgin Islander | ||
AMS SHANGHAI (LONDON) LIMITED | 01 nov. 2005 | 01 juin 2011 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | British Virgin Islander | |
JEMSTONE PROPERTIES LIMITED | 04 févr. 2004 | 01 avr. 2011 | Active | Company Director | Administrateur | Passer Chevern & Co 5 Spring Villa Road HA8 7EB Edgware Middlesex | Spain | British |
MEDIA RESCUE LIMITED | 18 mars 2009 | 27 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | British Virgin Islander | ||
PSL EQUIPMENT LIMITED | 21 juil. 2008 | 18 mars 2010 | Dissoute | Secrétaire | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | British Virgin Islander | ||
U K APPLIANCES LIMITED | 15 déc. 2003 | 11 déc. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 33 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JU London | British Virgin Islander |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0