Jonathan Embling DART
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Jonathan |
Deuxième prénom | Embling |
Nom de famille | DART |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 2 |
Démissionné | 27 |
Total | 30 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECK PARTNERSHIP LLP | 25 août 2015 | Active | Membre désigné de la LLP | Warren House 4, Wilbury Avenue SM2 7DU Cheam Warren House Surrey United Kingdom | England | |||
BECK KUWAIT LIMITED | 17 août 2015 | Dissoute | Finance Director | Administrateur | Cox Lane KT9 1SG Chessington Victory House Surrey United Kingdom | England | British | |
BECK INTERIORS KUWAIT LIMITED | 17 août 2015 | Dissoute | Finance Director | Administrateur | Cox Lane KT9 1SG Chessington Victory House Surrey United Kingdom | England | British | |
BECK SCOTLAND LIMITED | 17 août 2020 | 30 juin 2022 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Cox Lane KT9 1SG Chessington Victory House England | England | British |
UNUSUAL PROJECTS LTD | 15 août 2019 | 30 juin 2022 | Active | Company Director | Administrateur | Cox Lane Kt9 1sg KT9 1SG Chessington Victory House Surrey United Kingdom | England | British |
BECK INTERIORS HOLDINGS LIMITED | 21 déc. 2017 | 30 juin 2022 | Liquidation | Director | Administrateur | Victory House Cox Lane KT9 1SG Chessington Surrey | England | British |
BECK INTERIORS INTERNATIONAL LIMITED | 21 déc. 2017 | 30 juin 2022 | Liquidation | Director | Administrateur | Victory House Cox Lane KT9 1SG Chessington Surrey | England | British |
BECK GROUP LIMITED | 30 sept. 2016 | 30 juin 2022 | Liquidation | Company Director | Administrateur | Victory House Cox Lane KT9 1SG Chessington Surrey | England | British |
BECK MBI 2 LIMITED | 30 avr. 2015 | 30 juin 2022 | Liquidation | Finance Director | Administrateur | Cox Lane KT9 1SG Chessington Victory House Surrey United Kingdom | England | British |
BECK INTERIORS LIMITED | 01 janv. 2014 | 30 juin 2022 | En administration | Company Director | Administrateur | Victory House Cox Lane KT9 1SG Chessington Surrey | England | British |
BECK MBI LIMITED | 02 déc. 2013 | 30 juin 2022 | Liquidation | Financial Director | Administrateur | Victory House Cox Lane KT9 1SG Chessington Surrey | England | British |
BECK TRUSTEES LIMITED | 21 déc. 2017 | 11 oct. 2021 | Active | Director | Administrateur | Victory House Cox Lane KT9 1SG Chessington Surrey | England | British |
RESOURCE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | 30 juil. 2007 | 17 août 2009 | Liquidation | Company Director | Secrétaire | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British | |
RESOURCE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | 30 juil. 2007 | 17 août 2009 | Liquidation | Company Director | Administrateur | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | England | British |
DELTEC MAINTENANCE COMPANY LIMITED | 22 sept. 2006 | 17 août 2009 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British | |
DELTEC MAINTENANCE COMPANY LIMITED | 22 sept. 2006 | 17 août 2009 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | England | British |
COFATHEC ENERGY SERVICES LIMITED | 16 déc. 2005 | 17 août 2009 | Liquidation | Company Director | Secrétaire | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British | |
COFATHEC ENERGY SERVICES LIMITED | 16 déc. 2005 | 17 août 2009 | Liquidation | Company Director | Administrateur | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | England | British |
EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED | 16 déc. 2005 | 17 août 2009 | Liquidation | Company Director | Administrateur | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | England | British |
COFATHEC ENERGY LIMITED | 16 déc. 2005 | 17 août 2009 | Dissoute | Company | Administrateur | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | England | British |
EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED | 16 déc. 2005 | 17 août 2009 | Liquidation | Company Director | Secrétaire | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British | |
SALE PFI LIMITED | 26 févr. 2002 | 17 août 2009 | Active | Company Director | Administrateur | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | England | British |
SALE PFI LIMITED | 26 févr. 2002 | 17 août 2009 | Active | Company Director | Secrétaire | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British | |
SALE PFI FM LIMITED | 21 nov. 2001 | 17 août 2009 | Active | Finance Director | Administrateur | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | England | British |
SALE PFI FM LIMITED | 21 nov. 2001 | 17 août 2009 | Active | Finance Director | Secrétaire | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British | |
COFATHEC ENERGY PFI LIMITED | 06 avr. 2001 | 17 août 2009 | Liquidation | Secrétaire | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British | ||
COFATHEC HEATSAVE LIMITED | 12 sept. 2000 | 17 août 2009 | Liquidation | Secrétaire | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British | ||
COFATHEC UK LIMITED | 12 sept. 2000 | 17 août 2009 | Liquidation | Secrétaire | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British | ||
AIRTHERM LIMITED | 07 août 2000 | 17 août 2009 | Dissoute | Secrétaire | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British | ||
COFATHEC ENERGY LIMITED | 16 déc. 2005 | 17 août 2007 | Dissoute | Company | Secrétaire | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0