Bernard Joseph WALDRON
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Bernard |
Deuxième prénom | Joseph |
Nom de famille | WALDRON |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 1 |
Démissionné | 16 |
Total | 18 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEST BAR BPRA LLP | 03 avr. 2012 | Active | Membre de la LLP | Lower Thames Street EC3R 6AF London 10 England | England | |||
AYRESOME LIMITED | 27 févr. 2007 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Dragon House Pinley Green CV35 8LU Claverdon Warwickshire | England | British | |
OAKTREE BIDCO LIMITED | 30 avr. 2018 | 04 déc. 2021 | Active | Director | Administrateur | Unit 7, Acorn Business Park BD23 2UE Skipton Cpoms House North Yorkshire United Kingdom | England | British |
OAKTREE MIDCO LIMITED | 30 avr. 2018 | 04 déc. 2021 | Active | Director | Administrateur | Unit 7, Acorn Business Park BD23 2UE Skipton Cpoms House North Yorkshire United Kingdom | England | British |
OAKTREE TOPCO LIMITED | 30 avr. 2018 | 04 oct. 2021 | Active | Director | Administrateur | Unit 7, Acorn Business Park BD23 2UE Skipton Cpoms House North Yorkshire United Kingdom | England | British |
QUESTIONMARK COMPUTING LIMITED | 22 déc. 2016 | 09 juin 2021 | Active | Company Director | Administrateur | 22 Upper Ground South Bank SE1 9PD London New Kings Beam House England | England | British |
HOOK TOPCO LIMITED | 31 oct. 2019 | 01 avr. 2021 | Liquidation | Director | Administrateur | 60 Goswell Road EC1M 7AD London Devonshire House United Kingdom | England | British |
APSU USA LIMITED | 21 nov. 2016 | 22 janv. 2020 | Active | Independent Director | Administrateur | Warwick Road CV37 6YW Stratford Upon Avon 15 Warwickshire | England | British |
SIEMENS PROCESS SYSTEMS ENGINEERING LIMITED | 21 oct. 2008 | 25 oct. 2019 | Active | Company Director | Administrateur | Dragon House Pinley Green CV35 8LU Claverdon Warwickshire | England | British |
SERVELEC LIMITED | 01 nov. 2013 | 26 avr. 2017 | Active | Director | Administrateur | Rotherside Road Eckington S21 4HL Sheffield South Yorkshire | England | British |
GLORY GLOBAL SOLUTIONS LTD | 01 avr. 2014 | 31 mars 2017 | Active | Director | Administrateur | 1 Hazelwood, Lime Tree Way Chineham RG24 8WZ Basingstoke Infinity View, Hampshire England | England | British |
APSU HOLDINGS LIMITED | 14 août 2015 | 22 nov. 2016 | Dissoute | Independent Director | Administrateur | The Mallards South Cerney GL7 5TQ Cirencester Apsu House Gloucestershire | England | British |
NODE 4 HOLDINGS LIMITED | 24 mai 2013 | 04 oct. 2016 | Active | Director | Administrateur | Millennium Way Pride Park DE24 8HZ Derby Unit 1a-1b Derbyshire United Kingdom | England | British |
NODE 4 LIMITED | 24 mai 2013 | 04 oct. 2016 | Active | Director | Administrateur | Millennium Way Pride Park DE24 8HZ Derby Unit 1a-1b Derbyshire England | England | British |
PCI-PAL PLC | 01 janv. 2011 | 30 sept. 2014 | Active | Director | Administrateur | Melford Court, The Havens Ransomes Europark IP3 9SJ Ipswich 2 Suffolk United Kingdom | England | British |
IP REALISATIONS LTD | 01 janv. 2011 | 30 sept. 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Melford Court, The Havens Ransomes Europark IP3 9SJ Ipswich 2 Suffolk United Kingdom | England | British |
THE VENTURE PARTNERSHIP FOUNDATION LIMITED | 19 mars 2008 | 06 janv. 2014 | Active | Company Director | Administrateur | Dragon House Pinley Green CV35 8LU Claverdon Warwickshire | England | British |
THE VENTURE PARTNERSHIP FOUNDATION LIMITED | 01 oct. 2008 | 15 déc. 2011 | Active | Company Director | Secrétaire | Dragon House Pinley Green CV35 8LU Claverdon Warwickshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0