Vanessa Frances RUPAREL
Personne physique
Titre | Mrs |
---|---|
Prénom | Vanessa |
Deuxième prénom | Frances |
Nom de famille | RUPAREL |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 2 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 44 |
Total | 46 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSEC COMPLIANCE LIMITED | 14 févr. 2005 | Active | Company Secretary | Administrateur | Marlow Road RG9 2HZ Henley-On-Thames Swiss Farm Cottage Oxfordshire England | England | British | |
COSEC COMPLIANCE LIMITED | 14 févr. 2005 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Marlow Road RG9 2HZ Henley-On-Thames Swiss Farm Cottage Oxfordshire England | British | ||
SYNTHETIC RESINS LIMITED | 01 sept. 2005 | 31 déc. 2007 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 2 Denham Cottages Bullocks Farm Lane Wheeler End HP14 3NQ High Wycombe Bucks | British | |
SCOTT BADER COMPANY LIMITED | 01 sept. 2005 | 31 déc. 2007 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 2 Denham Cottages Bullocks Farm Lane Wheeler End HP14 3NQ High Wycombe Bucks | British | |
BOLDHELP LIMITED | 01 sept. 2005 | 31 déc. 2007 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 2 Denham Cottages Bullocks Farm Lane Wheeler End HP14 3NQ High Wycombe Bucks | British | |
STRAND GLASSFIBRE LIMITED | 01 sept. 2005 | 31 déc. 2007 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 2 Denham Cottages Bullocks Farm Lane Wheeler End HP14 3NQ High Wycombe Bucks | British | |
SCOTT BADER UK LIMITED | 01 sept. 2005 | 31 déc. 2007 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 2 Denham Cottages Bullocks Farm Lane Wheeler End HP14 3NQ High Wycombe Bucks | British | |
HYPAR TANK PANELS LIMITED | 01 sept. 2005 | 31 déc. 2007 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 2 Denham Cottages Bullocks Farm Lane Wheeler End HP14 3NQ High Wycombe Bucks | British | |
SCOTT BADER PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED | 01 sept. 2005 | 31 déc. 2007 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 2 Denham Cottages Bullocks Farm Lane Wheeler End HP14 3NQ High Wycombe Bucks | British | |
SCOTT BADER EXPORTS LIMITED | 01 sept. 2005 | 31 déc. 2007 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 2 Denham Cottages Bullocks Farm Lane Wheeler End HP14 3NQ High Wycombe Bucks | British | |
PRUDENTIAL DISTRIBUTION LIMITED | 02 nov. 2000 | 31 oct. 2001 | Active | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
EURO SALAS PROPERTIES LIMITED | 18 avr. 2000 | 01 août 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
CRAIGFORTH SERVICES LIMITED | 31 janv. 2000 | 25 juil. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
HYDE HOLDCO1 LIMITED | 26 janv. 2000 | 25 juil. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
PRUDENTIAL CAPITAL PUBLIC LIMITED COMPANY | 20 déc. 1999 | 02 juil. 2001 | Active | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
MM&S (2375) LIMITED | 13 janv. 2000 | 27 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
PRUDENTIAL PROPERTY SERVICES (BRISTOL) LIMITED | 12 janv. 2000 | 27 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
PPS TWELVE LIMITED | 12 janv. 2000 | 27 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
PRUDENTIAL LALONDES LIMITED | 12 janv. 2000 | 27 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 12 Winsdon Road LU1 5JT Luton Bedfordshire | British | ||
SNUSHALLS TEAM LIMITED | 12 janv. 2000 | 27 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
GEOFFREY SNUSHALL LIMITED | 12 janv. 2000 | 27 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
REEDS RAINS PRUDENTIAL LIMITED | 12 janv. 2000 | 27 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
PPS FIVE LIMITED | 12 janv. 2000 | 27 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
SCOTTISH AMICABLE FINANCE LIMITED | 17 déc. 1999 | 27 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
PRUDENTIAL GP LIMITED | 06 juil. 2000 | 06 juin 2001 | Active | Secretary | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | |
PPS NINE LIMITED | 12 janv. 2000 | 22 mai 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
GS TWENTY TWO LIMITED | 26 janv. 2000 | 19 avr. 2001 | Active | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
PACUS (UK) LIMITED | 18 avr. 2000 | 01 avr. 2001 | Active | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
PVM PARTNERSHIPS LIMITED | 18 avr. 2000 | 01 avr. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
SCOTTISH AMICABLE INVESTMENT PROPERTY LIMITED | 18 avr. 2000 | 01 avr. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
CATHEDRAL INVESTMENT PROPERTIES LIMITED | 18 avr. 2000 | 01 avr. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
WESTFIELD WHITE CITY SAGP LIMITED | 08 févr. 2000 | 01 avr. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
WESTFIELD WHITE CITY SALP LIMITED | 08 févr. 2000 | 01 avr. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
PRUTEC LIMITED | 18 avr. 2000 | 01 avr. 2001 | Liquidation | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | ||
PRUDENTIAL LIFETIME MORTGAGES LIMITED | 01 août 2000 | 05 févr. 2001 | Active | Secrétaire | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0