Andrew Louis STUART
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Andrew |
Deuxième prénom | Louis |
Nom de famille | STUART |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 6 |
Inactif | 5 |
Démissionné | 9 |
Total | 20 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGICUM LLP | 14 mai 2018 | Active | Membre désigné de la LLP | 2-8 Victoria Avenue EC2M 4NS London Longcroft House England | United Kingdom | |||
FITSMART TECHNOLOGY LIMITED | 01 juil. 2016 | Active | Accountant | Administrateur | 4385 CF14 8LH Cardiff 10259482 - Companies House Default Address | United Kingdom | British | |
BRANDWORX AGENCY LIMITED | 24 juin 2016 | Active | Accountant | Administrateur | 4385 CF14 8LH Cardiff 10249847 - Companies House Default Address | United Kingdom | British | |
INTERWALL FLOORING LIMITED | 22 juin 2016 | Active | Director | Administrateur | 4385 CF14 8LH Cardiff 10245498 - Companies House Default Address | United Kingdom | British | |
JTM CONSTRUCTION LTD | 20 avr. 2016 | Dissoute | Consultant | Administrateur | Great Portland Street Fifth Floor W1W 5PF London 167-169 Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
JTM LONDON LTD | 18 avr. 2016 | Dissoute | Consultant | Administrateur | Victoria Avenue EC2M 4NS London 2-8 United Kingdom | United Kingdom | British | |
INTERWALL LTD | 04 avr. 2016 | Dissoute | Consultant | Administrateur | Lincoln Way EN1 1DX Enfield 2 Haslemere Business Centre England | United Kingdom | British | |
GSI TRANSLATIONS LTD | 01 déc. 2015 | Active | Consultant | Administrateur | Green End Stretham CB6 3LE Ely 21 England | United Kingdom | British | |
GSI ASSOCIATES LIMITED | 20 oct. 2015 | Active | Accountant | Administrateur | Fifth Floor W1W 5PF London 167-169 Great Portland Street United Kingdom | United Kingdom | British | |
SRI THONG RESTAURANTS LIMITED | 01 août 2006 | Dissoute | Chartered Accountant | Secrétaire | Cromwell House 21 Green End CB6 3LE Ely Cambridgeshire | British | ||
LONDON GLOBAL LIMITED | 01 oct. 2004 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Cromwell House 21 Green End CB6 3LE Ely Cambridgeshire | United Kingdom | British | |
GSI MAINTENANCE LIMITED | 11 juin 2020 | 23 oct. 2023 | Active | Accountant | Administrateur | Great Portland Street 5th Floor W1W 5PF London 167-169 England | United Kingdom | British |
LOGICUM LIMITED | 30 nov. 2006 | 07 mars 2011 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Cromwell House 21 Green End CB6 3LE Ely Cambridgeshire | United Kingdom | British |
IC ROMANIA LIMITED | 21 févr. 2006 | 06 mars 2011 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Cromwell House 21 Green End CB6 3LE Ely Cambridgeshire | United Kingdom | British |
PREMIER BOXES LIMITED | 22 févr. 2005 | 06 mars 2011 | Active | Chartered Accountant | Administrateur | Cromwell House 21 Green End CB6 3LE Ely Cambridgeshire | United Kingdom | British |
MCINTYRE STUART LIMITED | 21 mai 2004 | 31 déc. 2010 | Active | Secrétaire | Cromwell House 21 Green End CB6 3LE Ely Cambridgeshire | British | ||
SRI THONG RESTAURANTS LIMITED | 01 août 2006 | 26 juin 2009 | Dissoute | Chartered Accountant | Administrateur | Cromwell House 21 Green End CB6 3LE Ely Cambridgeshire | United Kingdom | British |
BASICALLY CRATES LTD | 14 oct. 1997 | 01 déc. 2000 | Dissoute | Secrétaire | Cromwell House 21 Green End CB6 3LE Ely Cambridgeshire | British | ||
BASICALLY BOXES LIMITED | 10 juil. 1997 | 01 déc. 2000 | Dissoute | Secrétaire | Cromwell House 21 Green End CB6 3LE Ely Cambridgeshire | British | ||
BOXES LIMITED | 27 juin 1997 | 01 déc. 2000 | Dissoute | Secrétaire | Cromwell House 21 Green End CB6 3LE Ely Cambridgeshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0