Andrew Thomas William RYAN
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Andrew |
Deuxième prénom | Thomas William |
Nom de famille | RYAN |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 9 |
Démissionné | 12 |
Total | 21 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREATFIELD FLORAL DESIGNS LIMITED | 02 févr. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 37 Warren Road SM7 1LG Banstead Surrey | British | |||
PORTLAND CRESCENT LEEDS LIMITED | 09 juil. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 58 Spring Gardens M2 1EW Manchester The Chancery | British | |||
GB BUILDING SOLUTIONS LIMITED | 04 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Temple Street L2 5RH Liverpool 5 Temple Square | British | |||
OXFORD GB THREE LIMITED | 27 juil. 2007 | Dissoute | Secrétaire | c/o Fa Simms & Partners Woodway Lane Claybrooke Parva LE17 5FB Lutterworth Alma Park Leicestershire England | British | |||
GB GROUP HOLDINGS LIMITED | 29 déc. 2006 | Dissoute | Secrétaire | c/o Bdo Llp Baker Street W1U 7EU London 55 | British | |||
OXFORD GB ONE LTD | 12 mai 2006 | Dissoute | Secrétaire | c/o Fa Simms & Partners Woodway Lane Claybrooke Parva LE17 5FB Lutterworth Alma Park Leicestershire England | British | |||
OXFORD GB TWO LTD | 12 mai 2006 | Dissoute | Secrétaire | Spring Gardens M2 1EW Manchester 58 | British | |||
OXFORD GB LTD | 23 mars 2006 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 58 Spring Gardens M2 1EW Manchester The Chancery | British | ||
GB DEVELOPMENT SOLUTIONS LIMITED | 10 févr. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Baker Street W1U 7EU London 55 | British | |||
GLEESON BUILDING LIMITED | 04 déc. 2006 | 30 sept. 2015 | Dissoute | Secrétaire | Church Road Seal Chart TN15 0HA Sevenoaks Chartfield Kent England | British | ||
GB MANAGED PROPERTY SOLUTIONS LIMITED | 10 févr. 2006 | 30 sept. 2015 | Dissoute | Secrétaire | Church Road Seal Chart TN15 0HA Sevenoaks Chartfield Kent England | British | ||
GB HOMES LIMITED | 10 févr. 2006 | 30 sept. 2015 | Dissoute | Secrétaire | Church Road Seal Chart TN15 0HA Sevenoaks Chartfield Kent England | British | ||
GB BUILDING LIMITED | 25 août 2005 | 30 sept. 2015 | Dissoute | Secrétaire | Church Road Seal Chart TN15 0HA Sevenoaks Chartfield Kent England | British | ||
OXFORD HOTELS LIMITED | 25 janv. 2007 | 09 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 37 Warren Road SM7 1LG Banstead Surrey | British | ||
GLEESON PFI INVESTMENTS LIMITED | 20 janv. 2005 | 16 sept. 2005 | Active | Secrétaire | 30 Ross Road SM6 8QR Wallington Surrey | British | ||
GLEESON CAPITAL SOLUTIONS LIMITED | 02 nov. 2004 | 16 sept. 2005 | Active | Secrétaire | 30 Ross Road SM6 8QR Wallington Surrey | British | ||
GLEESON LAND LIMITED | 16 juil. 2004 | 16 sept. 2005 | Active | Secrétaire | 30 Ross Road SM6 8QR Wallington Surrey | British | ||
GLEESON PROPERTIES (PETERSFIELD) LIMITED | 16 mars 2004 | 16 sept. 2005 | Active | Secrétaire | 30 Ross Road SM6 8QR Wallington Surrey | British | ||
CAVENDISH GLEESON SECOND LIMITED | 18 févr. 2005 | 16 sept. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 30 Ross Road SM6 8QR Wallington Surrey | British | ||
DENBIGH GLEESON (CAP GREEN) LIMITED | 03 août 2004 | 16 sept. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 30 Ross Road SM6 8QR Wallington Surrey | British | ||
GENESIS ESTATES (MANCHESTER) LIMITED | 26 mars 2001 | 15 sept. 2005 | Active | Secrétaire | 30 Ross Road SM6 8QR Wallington Surrey | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0