Sarah Marie Davenport CHRISTIE
Personne physique
Titre | Mrs |
---|---|
Prénom | Sarah |
Deuxième prénom | Marie Davenport |
Nom de famille | CHRISTIE |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 40 |
Total | 40 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C & S CHRISTIE LIMITED | 13 mai 1999 | 16 mars 2025 | Active | Secrétaire | 1 Nalton Close Copmanthorpe YO23 3YY York North Yorkshire | British | ||
C & S CHRISTIE LIMITED | 13 mai 1999 | 16 mars 2025 | Active | Teacher | Administrateur | 1 Nalton Close Copmanthorpe YO23 3YY York North Yorkshire | England | British |
PLASTIC IDEAS LIMITED | 13 févr. 2004 | 27 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 1 Nalton Close Copmanthorpe YO23 3YY York North Yorkshire | British | ||
BAND CONSULTING SERVICES LIMITED | 05 févr. 2004 | 21 oct. 2007 | Active | Secrétaire | 1 Nalton Close Copmanthorpe YO23 3YY York North Yorkshire | British | ||
PINEAPPLE DINERS LIMITED | 07 juin 2005 | 07 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 1 Nalton Close Copmanthorpe YO23 3YY York North Yorkshire | British | ||
HOMEPOWER RETAIL LIMITED | 13 nov. 1998 | 31 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YELECO 29 LIMITED | 28 sept. 1998 | 31 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (SEP) | 29 juil. 1998 | 31 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT INVESTMENTS LIMITED | 29 juil. 1998 | 31 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (DEC) | 23 juil. 1998 | 31 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (MAR) UNLIMITED | 23 juil. 1998 | 31 oct. 2001 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | |
NVISAGE | 23 juil. 1998 | 31 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (6) UNLIMITED | 23 juil. 1998 | 31 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (3) | 23 juil. 1998 | 31 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (4) | 23 juil. 1998 | 31 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
METERPLUS LIMITED | 21 juil. 1998 | 31 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YORKSHIRE ELECTRICITY DISTRIBUTION SERVICES LIMITED | 22 nov. 2000 | 06 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
NORTHERN POWERGRID (YORKSHIRE) PLC | 22 nov. 2000 | 24 janv. 2001 | Active | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YEDL LIMITED | 22 nov. 2000 | 24 janv. 2001 | Active | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YORKSHIRE ELECTRICITY GROUP SHARE SCHEME TRUSTEES LIMITED | 08 janv. 1999 | 16 avr. 1999 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
E.ON UK GREEN FUNDING SOLUTIONS LIMITED | 08 sept. 1998 | 31 déc. 1998 | Active | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
CBS ENERGY STORAGE ASSETS UK LIMITED | 01 sept. 1998 | 25 nov. 1998 | Active | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
BRIGHT SOLUTIONS (LEEDS) LIMITED | 21 août 1998 | 02 sept. 1998 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YE GAS LIMITED | 26 juin 1995 | 12 janv. 1998 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YORKSHIRE WINDPOWER LIMITED | 19 sept. 1996 | 15 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YORKSHIRE ENERGY LIMITED | 03 août 1995 | 15 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
METERPLUS LIMITED | 29 août 1996 | 08 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
YELECO 29 LIMITED | 29 août 1996 | 28 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT INVESTMENTS LIMITED | 30 juin 1995 | 28 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (MAR) UNLIMITED | 14 juin 1995 | 14 nov. 1997 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | |
NVISAGE | 14 juin 1995 | 14 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (SEP) | 31 mai 1995 | 14 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (DEC) | 31 mai 1995 | 14 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (6) UNLIMITED | 31 mai 1995 | 14 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British | ||
SCARCROFT LEASING (3) | 31 mai 1995 | 14 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 29 Millfield Road YO2 1NH York North Yorkshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0