Alan Charles WALLWORK
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Alan |
Deuxième prénom | Charles |
Nom de famille | WALLWORK |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 28 |
Total | 29 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLACIER FOODS LIMITED | Liquidation | Chartered Secretary | Administrateur | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | |||
SCAPA BLACKBURN LIMITED | 29 juin 1999 | 30 sept. 1999 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | |
SCAPA DENVER (NORTH) LIMITED | 09 oct. 1998 | 30 sept. 1999 | Active | Secrétaire | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | ||
PORRITTS & SPENCER LIMITED | 18 sept. 1997 | 30 sept. 1999 | Active | Company Secretary | Administrateur | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | |
SCAPA UK LIMITED | 09 juil. 1997 | 30 sept. 1999 | Active | Company Secretary | Administrateur | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | |
SCAPA GROUP LIMITED | 24 oct. 1996 | 30 sept. 1999 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | |
PORRITTS & SPENCER LIMITED | 14 oct. 1996 | 30 sept. 1999 | Active | Secrétaire | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | ||
SCAPA DENVER (SOUTH) LIMITED | 09 oct. 1998 | 30 sept. 1999 | Dissoute | Secrétaire | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | ||
LINDSAY & WILLIAMS LIMITED | 09 juil. 1997 | 30 sept. 1999 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | |
SCAPA EUROPE LIMITED | 14 oct. 1996 | 30 sept. 1999 | Dissoute | Secrétaire | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | ||
SCAPA HOLDINGS LIMITED | 14 oct. 1996 | 30 sept. 1999 | Dissoute | Secrétaire | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | ||
SCAPA ENGINEERING LIMITED | 27 mai 1996 | 30 sept. 1999 | Liquidation | Company Secretary | Administrateur | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | |
VOITH PAPER FABRICS BLACKBURN LIMITED | 30 avr. 1999 | 06 mai 1999 | Dissoute | Chartered Secretary | Secrétaire | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | |
VOITH PAPER FABRICS BLACKBURN LIMITED | 30 avr. 1999 | 06 mai 1999 | Dissoute | Chartered Secretary | Administrateur | 14 Selworthy Road Birkdale PR8 2NS Southport Merseyside | British | |
GLENEAGLES ESTATE LIMITED | 22 août 1995 | 22 août 1996 | Active | Cs | Administrateur | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | |
J. LYONS & COMPANY LIMITED | 01 mai 1996 | Active | Secrétaire | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | |||
GLENEAGLES ESTATE LIMITED | 01 févr. 1996 | Active | Secrétaire | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | |||
STRAND HOTELS LIMITED(THE) | 01 janv. 1996 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | ||
ZOO GIRL (MOBILE) LIMITED | 01 janv. 1996 | Dissoute | Chartered Secretary | Administrateur | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | ||
ZOO GIRL LIMITED | 01 janv. 1996 | Dissoute | Chartered Secretary | Administrateur | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | ||
LYONS BAKERY LIMITED | 01 janv. 1996 | Dissoute | Chartered Secretary | Administrateur | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | ||
LYONS CATERING SUPPLIES LIMITED | 01 janv. 1996 | Dissoute | Secrétaire | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | |||
LYONS CATERING SUPPLIES LIMITED | 01 janv. 1996 | Dissoute | Chartered Secretary | Administrateur | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | ||
J. LYONS FOOD PRODUCTS LIMITED | 01 janv. 1996 | Liquidation | Chartered Secretary | Administrateur | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | ||
A.G. (PATENTS) LIMITED | 31 déc. 1995 | Dissoute | Chartered Secretary | Administrateur | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | ||
KERRY INGREDIENTS (UK) LIMITED | 29 déc. 1994 | Active | Secrétaire | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | |||
DANMAID LIMITED | 01 déc. 1994 | Active | Secrétaire | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | |||
THE CASTLE TEA CO. LIMITED | 22 oct. 1992 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British | ||
MOTHERCARE FINANCE OVERSEAS LIMITED | 04 nov. 1986 | 01 avr. 1987 | Converti / Fermé | Secrétaire | 8 Windmill Hill HP27 0EP Princes Risborough Buckinghamshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0