• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Anne Catherine RAMSAY

    Personne physique

    Titre
    PrénomAnne
    Deuxième prénomCatherine
    Nom de familleRAMSAY
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif0
    Inactif2
    Démissionné39
    Total41

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    CARILLION PRIVATE FINANCE (SECURE) LIMITED24 avr. 2008DissouteSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    G4S CARILLION LIMITED28 sept. 2007DissouteSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    CLINICENTA (HERTFORDSHIRE) LIMITED15 avr. 200919 déc. 2018DissouteSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    CARILLION PRIVATE FINANCE (TRANSPORT) LIMITED24 avr. 200819 déc. 2018DissouteSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    CARILLION PRIVATE FINANCE LIMITED24 avr. 200819 déc. 2018LiquidationSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    CLINICENTA LIMITED28 sept. 200719 déc. 2018LiquidationSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES DURHAM (PSP1) LIMITED13 août 200903 sept. 2018ActiveSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES DURHAM LIMITED13 août 200903 sept. 2018ActiveSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES TAMESIDE (PSP2) LIMITED16 juin 200803 sept. 2018ActiveSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES TAMESIDE (PSP1) LIMITED16 juin 200803 sept. 2018ActiveSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES TAMESIDE LIMITED16 juin 200803 sept. 2018ActiveSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES NOTTINGHAM (PSP1) LIMITED01 avr. 200803 sept. 2018ActiveSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES STAG LIMITED20 déc. 200703 sept. 2018ActiveSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES STAG (PSP1) LIMITED20 déc. 200703 sept. 2018ActiveSecrétaire
    7-12 Tavistock Street
    WC1H 9LT London
    Lynton House, 2nd Floor
    United Kingdom
    Other
    STAG PCT (HOLDCO) LIMITED23 avr. 200826 avr. 2018ActiveSecrétaire
    10-12 Russell Square
    Bloomsbury
    WC1B 5EH London
    Russell Square House
    United Kingdom
    Other
    STAG PCT (PROJECTCO) LIMITED23 avr. 200826 avr. 2018ActiveSecrétaire
    10-12 Russell Square
    Bloomsbury
    WC1B 5EH London
    Russell Square House
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES NOTTINGHAM LIMITED01 avr. 200806 févr. 2018ActiveSecrétaire
    10-12 Russell Square
    Bloomsbury
    WC1B 5EH London
    Russell Square House
    United Kingdom
    Other
    EASTBURY PARK LIMITED28 sept. 200728 juil. 2017ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    EASTBURY PARK (HOLDINGS) LIMITED28 sept. 200728 juil. 2017ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    SHEPPEY ROUTE LIMITED28 sept. 200701 déc. 2016ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    SHEPPEY ROUTE (HOLDINGS) LIMITED28 sept. 200701 déc. 2016ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (HEALTH) LIMITED24 avr. 200830 juin 2015ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (DEFENCE) LIMITED24 avr. 200824 déc. 2013ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES DURHAM (PROJECTCO1) LIMITED13 août 200926 sept. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES DURHAM (HOLDINGS1) LIMITED13 août 200926 sept. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES DURHAM (PSP2) LIMITED13 août 200926 sept. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    BSF NEWCO LIMITED24 avr. 200826 sept. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES NOTTINGHAM (HOLDINGS1) LIMITED01 avr. 200826 sept. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES NOTTINGHAM (PROJECTCO1) LIMITED01 avr. 200826 sept. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES NOTTINGHAM (PSP2) LIMITED01 avr. 200826 sept. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES STAG (PSP2) LIMITED20 déc. 200726 sept. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES STAG (PROJECTCO1) LIMITED20 déc. 200726 sept. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES STAG (HOLDINGS1) LIMITED20 déc. 200726 sept. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES TAMESIDE (PROJECTCO1) LIMITED16 juin 200824 juil. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other
    INSPIREDSPACES TAMESIDE (HOLDINGS1) LIMITED16 juin 200824 juil. 2012ActiveSecrétaire
    Maddox Street
    W1S 2QN London
    25
    United Kingdom
    Other

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0