Deborah PEPPIN
Personne physique
| Titre | Mrs |
|---|---|
| Prénom | Deborah |
| Nom de famille | PEPPIN |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 2 |
| Inactif | 12 |
| Démissionné | 5 |
| Total | 19 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIERSHIP SOLUTIONS & SERVICES LTD | 02 oct. 2020 | Dissoute | Administrateur | Coopers Hill Lane Englefield Green TW20 0LB Egham Cheylesmore Cottage England | England | British | ||
| CLOUDA2K LIMITED | 30 mai 2019 | Dissoute | Administrateur | Drake Avenue TW18 2AP Staines-Upon-Thames Cadline House Middlesex United Kingdom | England | British | ||
| GDPR DESIGN LTD | 06 mars 2018 | Dissoute | Administrateur | Thatcham Business Village, Colthrop Way Colthrop Way RG19 4LW Thatcham 13 Berkshire United Kingdom | England | British | ||
| MEMORABLE MARQUEES LIMITED | 04 sept. 2012 | Dissoute | Administrateur | c/o Unit 12 The Business Village Business Village, Wexham Road SL2 5HF Slough Unit 12 Berkshire United Kingdom | England | British | ||
| LAST MINUTE TRIP ADVISOR LIMITED | 17 oct. 2009 | Dissoute | Administrateur | Drake Avenue TW18 2AP Staines Northumberland House Middlesex England | England | British | ||
| LAST MINUTE TRIP LIMITED | 09 oct. 2009 | Dissoute | Administrateur | Drake Avenue TW18 2AP Staines Northumberland House Middlesex England | England | British | ||
| CYMAP LIMITED | 07 nov. 2007 | Dissoute | Administrateur | Cheylesmore Cottage Coopers Hill Lane, Englefield Green TW20 0LB Egham Surrey | England | British | ||
| CYMAP LIMITED | 07 nov. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Cheylesmore Cottage Coopers Hill Lane, Englefield Green TW20 0LB Egham Surrey | British | |||
| MIDAS TECHNOLOGY LIMITED | 16 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Cheylesmore Cottage Coopers Hill Lane, Englefield Green TW20 0LB Egham Surrey | British | |||
| MIDAS TECHNOLOGY LIMITED | 16 nov. 2006 | Dissoute | Administrateur | Cheylesmore Cottage Coopers Hill Lane, Englefield Green TW20 0LB Egham Surrey | England | British | ||
| ACERI SOLUTIONS LTD | 16 déc. 1999 | Dissoute | Administrateur | Cheylesmore Cottage Coopers Hill Lane, Englefield Green TW20 0LB Egham Surrey | England | British | ||
| ACERI SOLUTIONS LTD | 16 déc. 1999 | Dissoute | Secrétaire | Cheylesmore Cottage Coopers Hill Lane, Englefield Green TW20 0LB Egham Surrey | British | |||
| ELECTROPOINT LIMITED | 08 nov. 1995 | Active | Administrateur | Cheylesmore Cottage Coopers Hill Lane, Englefield Green TW20 0LB Egham Surrey | England | British | ||
| ELECTROPOINT LIMITED | 08 nov. 1995 | Active | Secrétaire | Cheylesmore Cottage Coopers Hill Lane, Englefield Green TW20 0LB Egham Surrey | British | |||
| ARKANCE UK LIMITED | 31 mai 2023 | Active | Secrétaire | 11 Roedean Way BN2 5RJ Brighton The Mount England | British | |||
| ARKANCE UK LIMITED | 31 mai 2023 | Active | Administrateur | 11 Roedean Way BN2 5RJ Brighton 11 England | England | British | ||
| CLIC 2 LTD | 28 juin 2000 | 08 mars 2013 | Dissoute | Administrateur | Cheylesmore Cottage Coopers Hill Lane, Englefield Green TW20 0LB Egham Surrey | England | British | |
| TICCO FOODS LIMITED | 13 oct. 1994 | 24 avr. 2008 | Active | Administrateur | Cheylesmore Cottage Coopers Hill Lane, Englefield Green TW20 0LB Egham Surrey | England | British | |
| INDEPENDENT SERVICE COMPANY LIMITED | 29 oct. 1996 | 18 mars 2008 | Active | Administrateur | Cheylesmore Cottage Coopers Hill Lane, Englefield Green TW20 0LB Egham Surrey | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0