Ian ZANT BOER
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Ian |
Nom de famille | ZANT BOER |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 5 |
Démissionné | 146 |
Total | 151 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBP REALISATIONS LIMITED | 11 mai 2007 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | United Kingdom | British | |
TOWER VIDEO INVESTMENTS LIMITED | 30 juin 2006 | Dissoute | Secrétaire | Seebeck House One Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Buckinghamshire | British | |||
TEPEE CAPITAL LIMITED | 28 avr. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | British | |||
01101477 LIMITED | 29 août 2000 | Dissoute | Secrétaire | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | British | |||
VALLEYHALL LIMITED | 09 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | British | |||
WEYBRIDGE SPRINT LIMITED | 20 avr. 2020 | 17 févr. 2025 | Active | Venture Capital | Administrateur | Meryton House Longbourn Windsor 2 Berkshire England | England | British |
SEEBECK 71 LIMITED | 11 mai 2007 | 14 mai 2021 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | England | British |
THE ROGER KNIGHT PARTNERSHIP LIMITED | 29 juin 1993 | 03 juil. 2019 | Active | Secrétaire | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire | British | ||
VIEWTONE LIMITED | 03 janv. 1997 | 06 juin 2018 | Active | Secrétaire | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire | British | ||
EMW SECRETARIES LIMITED | 10 mars 1998 | 31 mars 2018 | Active | Solicitor | Administrateur | c/o Emw 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | England | British |
EMW DIRECTORS LIMITED | 11 févr. 1998 | 31 mars 2018 | Active | Solicitor | Administrateur | c/o Emw Picton Howell Llp 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire | England | British |
EMW GROUP LIMITED | 13 févr. 1996 | 31 mars 2018 | Active | Solicitor | Secrétaire | c/o Emw Picton Howell Llp 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | British | |
EMW GROUP LIMITED | 13 févr. 1996 | 01 avr. 2016 | Active | Solicitor | Administrateur | c/o Emw Picton Howell Llp 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | England | British |
EXPRESS PARK (KETTERING) MANAGEMENT LIMITED | 28 sept. 2007 | 14 juin 2013 | Active | Secrétaire | Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes 1 Seebeck House Buckinghamshire | British | ||
SECKLOE 93 LIMITED | 15 janv. 2002 | 30 juil. 2012 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Seebeck House 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Emw Picton Howell Llp Buckinghamshire | England | British |
IRISYS TRUSTEES LIMITED | 21 sept. 2001 | 20 juin 2012 | Dissoute | Secrétaire | Seebeck House 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Emw Picton Howell Llp Buckinghamshire | British | ||
IRISYS TRUSTEES LIMITED | 21 sept. 2001 | 20 juin 2012 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Park Circle Tithe Barn Way Swan Valley NN4 9BG Northampton Northamptonshire | England | British |
IRISYS LIMITED | 24 juin 1999 | 20 juin 2012 | Dissoute | Secrétaire | Seebeck House 1 Seebeck Place Knowhill MK5 8FR Milton Keynes Emw Picton Howell Llp Buckinghamshire | British | ||
HL2012 LIMITED | 05 sept. 2008 | 08 juin 2011 | Active | Solicitor | Administrateur | c/o Emw Picton Howell Llp Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House 1 Buckinghamshire | United Kingdom | British |
HOTBED GENERAL PARTNER LIMITED | 21 juin 2007 | 08 juin 2011 | Active | Solicitor | Administrateur | c/o Emw Picton Howell Llp Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House 1 Buckinghamshire | United Kingdom | British |
HOTBED GENERAL PARTNER (GROUND RENTS) LIMITED | 20 nov. 2009 | 08 juin 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire | England | British |
HOTBED GENERAL PARTNER (GROUND RENTS) NOMINEE LIMITED | 20 nov. 2009 | 08 juin 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire | England | British |
HOTBED ST CLEMENTS NOMINEE LIMITED | 01 avr. 2009 | 08 juin 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | c/o Emw Picton Howell Llp Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House 1 Buckinghamshire | United Kingdom | British |
HLPL2012 LIMITED | 21 juin 2007 | 08 juin 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Seebeck House 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Emw Picton Howell Llp Buckinghamshire | England | British |
HOTBED GROUP LIMITED | 23 juin 2005 | 08 juin 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | c/o Emw Picton Howell Llp Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House 1 Buckinghamshire | United Kingdom | British |
GHH OLDCO 5 LIMITED | 11 mai 2007 | 28 août 2009 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | England | British |
HLL GROUP LTD | 02 juil. 2009 | 05 juil. 2009 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | England | British |
HELENA LEISURE 28 LIMITED | 20 oct. 2008 | 05 juil. 2009 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | England | British |
ELSTREE COMPUTING LIMITED | 06 déc. 1995 | 29 mai 2009 | Dissoute | Secrétaire | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | British | ||
CAPITAL PROPERTIES MK LIMITED | 15 mars 2006 | 22 avr. 2009 | Dissoute | Secrétaire | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | British | ||
SAMAC ASSOCIATES LIMITED | 01 mars 2001 | 27 févr. 2009 | Dissoute | Secrétaire | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | British | ||
BOGGLE LIMITED | 13 sept. 2006 | 02 juil. 2008 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | England | British |
BIO DEPOT LIMITED | 20 avr. 2006 | 01 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | British | ||
VEHICLES 4 LESS LIMITED | 09 déc. 2005 | 26 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | British | ||
HL2012 LIMITED | 16 déc. 2005 | 13 sept. 2007 | Active | Solicitor | Administrateur | Garden Cottage Little Court NN12 8HE Farthingstone Northamptonshire | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0