• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Nicholas Paul LANDER

    Personne physique

    TitreMr
    PrénomNicholas
    Deuxième prénomPaul
    Nom de familleLANDER
    Date de naissance
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif12
    Inactif9
    Démissionné25
    Total46

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    SCOTLANDER LIMITED30 déc. 2024ActiveChartered AccountantAdministrateur
    Houston Road
    PA13 4NY Kilmacolm
    Highmuir House
    Renfrewshire
    EnglandBritish
    NAUGHTY VEGAN LIMITED14 févr. 2020ActiveDirectorAdministrateur
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    EnglandBritish
    VOLVERE ASSET MANAGEMENT LIMITED14 févr. 2020DissouteDirectorAdministrateur
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    EnglandBritish
    INDULGENCE PATISSERIE LIMITED17 avr. 2015ActiveCompany DirectorAdministrateur
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish
    D2L PARTNERS LLP23 mai 2012ActiveMembre désigné de la LLP
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    England
    D2L CAPITAL LIMITED21 mai 2012DissouteChartered AccountantAdministrateur
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish
    INDULGENCE FOODS LIMITED08 mars 2012ActiveNoneAdministrateur
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish
    SHIRE FOODS LIMITED29 juil. 2011ActiveNoneAdministrateur
    Tachbrook Road
    Leamington Spa
    CV31 3SF Warwickshire
    EnglandBritish
    IMPETUS AUTOMOTIVE SOLUTIONS LIMITED26 sept. 2008DissouteDirectorAdministrateur
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish
    IMPETUS AUTOMOTIVE SOLUTIONS LIMITED26 sept. 2008DissouteSecrétaire
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    British
    VOLVERE CENTRAL SERVICES LIMITED26 juin 2006ActiveChartered AccountantAdministrateur
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish
    VOLVERE CENTRAL SERVICES LIMITED26 juin 2006ActiveSecrétaire
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    British
    NEW MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED14 oct. 2005DissouteSecrétaire
    c/o Wright, Johnston & Mackenzie Llp
    St. Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    302
    Scotland
    Scotland
    British
    ZERO-STIK LIMITED14 oct. 2005DissouteSecrétaire
    c/o Wright, Johnston & Mackenzie Llp
    St. Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    302
    British
    NMT GROUP LIMITED12 oct. 2005ActiveSecrétaire
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    British
    NMT GROUP LIMITED14 sept. 2005ActiveChartered AccountantAdministrateur
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish
    NEW MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED14 sept. 2005DissouteChartered AccountantAdministrateur
    c/o Wright, Johnston & Mackenzie Llp
    St. Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    302
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritish
    ZERO-STIK LIMITED14 sept. 2005DissouteChartered AccountantAdministrateur
    c/o Wright, Johnston & Mackenzie Llp
    St. Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    302
    EnglandBritish
    DAWNAY, DAY LANDER LIMITED01 juil. 2004DissouteCh AccountantAdministrateur
    15-17 Roebuck Road
    Hainault Business Park
    IG8 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    EnglandBritish
    VOLVERE PLC15 nov. 2002ActiveChartered AccountantAdministrateur
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish
    VOLVERE PLC15 nov. 2002ActiveSecrétaire
    Tachbrook Road
    CV31 3SF Leamington Spa
    Shire House
    Warwickshire
    England
    British
    SIRA DEFENCE & SECURITY LIMITED28 mars 200623 mai 2019DissouteChartered AccountantAdministrateur
    Tollbar Way
    Hedge End
    SO30 2ZP Southampton
    Tollbar House
    England
    EnglandBritish
    SIRA DEFENCE & SECURITY LIMITED28 mars 200623 mai 2019DissouteSecrétaire
    Tollbar Way
    Hedge End
    SO30 2ZP Southampton
    Tollbar House
    England
    British
    EUROFINS E&E CML LIMITED01 juil. 201522 janv. 2019ActiveChartered AccountantAdministrateur
    Newport Business Park
    New Port Road
    CH65 4LZ Ellesmere Port
    Unit 1
    EnglandBritish
    IMPETUS AUTOMOTIVE LIMITED26 mars 201504 oct. 2018ActiveChartered AccountantAdministrateur
    Tournament Court
    Edgehill Drive
    CV34 6LG Warwick
    Impetus Automotive
    EnglandBritish
    JMP CONSULTING LIMITED28 avr. 201418 déc. 2015DissouteChartered AccountantAdministrateur
    Old Jewry
    EC2R 8DQ London
    27-32
    England
    EnglandBritish
    JMP CONSULTANTS LIMITED27 juil. 201217 déc. 2015DissouteCompany DirectorAdministrateur
    Old Jewry
    EC2R 8DQ London
    27-32
    England
    EnglandBritish
    INTERACTIVE PROSPECT TARGETING LIMITED26 sept. 200812 déc. 2013ActiveSecrétaire
    74-82 Queen Victoria Street
    EC4N 4SJ London
    York House
    British
    INTERACTIVE PROSPECT TARGETING LIMITED26 sept. 200812 déc. 2013ActiveDirectorAdministrateur
    74-82 Queen Victoria Street
    EC4N 4SJ London
    York House
    EnglandBritish
    TECTONIC GOLD PLC04 mars 201016 nov. 2010ActiveChartered AccountantAdministrateur
    c/o Dawnay, Day Lander
    74-82 Queen Victoria Street
    EC4N 4SJ London
    York House
    England
    EnglandBritish
    SIRA CONSULTING LIMITED08 mars 200703 juil. 2009DissouteChartered AccountantAdministrateur
    Silver Howe 6 Ryders
    Langton Green
    TN3 0DX Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish
    SIRA CONSULTING LIMITED08 mars 200703 juil. 2009DissouteChartered AccountantSecrétaire
    Silver Howe 6 Ryders
    Langton Green
    TN3 0DX Tunbridge Wells
    Kent
    British
    SIRA CERTIFICATION SERVICE LIMITED28 mars 200603 juil. 2009DissouteSecrétaire
    Silver Howe 6 Ryders
    Langton Green
    TN3 0DX Tunbridge Wells
    Kent
    British
    SIRA ENVIRONMENTAL LIMITED22 mars 200603 juil. 2009DissouteChartered AccountantAdministrateur
    Silver Howe 6 Ryders
    Langton Green
    TN3 0DX Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish
    SIRA ENVIRONMENTAL LIMITED22 mars 200603 juil. 2009DissouteChartered AccountantSecrétaire
    Silver Howe 6 Ryders
    Langton Green
    TN3 0DX Tunbridge Wells
    Kent
    British

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0