Susan Elizabeth STONEMAN
Personne physique
| Titre | |
|---|---|
| Prénom | Susan |
| Deuxième prénom | Elizabeth |
| Nom de famille | STONEMAN |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 0 |
| Démissionné | 107 |
| Total | 107 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB SUCCESS SYSTEMS LIMITED | 03 mars 2000 | 30 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| SHOOSMITHS SECRETARIES LIMITED | 31 mai 1996 | 20 janv. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| THE A. & M. ENGINEERING CO. (RUGBY) LIMITED | 06 mai 1998 | 31 juil. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| INDUSTRIAL RUBBER MOULDINGS LIMITED | 17 févr. 1998 | 30 juil. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| CAVENDISH ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 27 mars 1998 | 27 juil. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| DURR DENTAL (PRODUCTS) UK LIMITED | 06 mai 1998 | 04 juin 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| ACUCORP LIMITED | 06 mai 1998 | 29 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| KPN (CONSULTANTS) LIMITED | 07 avr. 1998 | 27 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| WESTCOAST RETAIL SERVICES LIMITED | 02 déc. 1997 | 26 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| PROFESSIONAL EDGE RESOURCING LIMITED | 18 mars 1998 | 18 mai 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| MOTORCYCLING GREAT BRITAIN LIMITED | 27 janv. 1998 | 05 mai 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| YOUTH MOTOCROSS GREAT BRITAIN LIMITED | 02 déc. 1997 | 05 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| GLOBAL LAND LIMITED | 12 févr. 1998 | 27 avr. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| VIVOBAREFOOT LIMITED | 02 déc. 1997 | 08 avr. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| THRUPP FARMS LIMITED | 19 nov. 1997 | 12 mars 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| WHITSAND BAY DEVELOPMENTS LIMITED | 12 févr. 1998 | 26 févr. 1998 | Liquidation | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| ROHAN GROUP LIMITED | 27 janv. 1998 | 18 févr. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| INDUSTRIAL RUBBER LIMITED | 19 nov. 1997 | 13 févr. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| KELGALE LIMITED | 14 févr. 1997 | 13 févr. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| FORMOST AIR-CONDITIONING LIMITED | 27 oct. 1997 | 09 févr. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| HEYGATE ANIMAL FEEDS LIMITED | 18 mars 1997 | 05 févr. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| M FOR TECHNOLOGIES LIMITED | 19 nov. 1997 | 14 janv. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| CALVERLEY (2004) LIMITED | 09 oct. 1997 | 08 janv. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| S&P REALISATIONS 2023 LIMITED | 01 sept. 1997 | 08 janv. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| ANDARIS GROUP LIMITED | 10 juil. 1997 | 18 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| VARIORUM PUBLISHING LIMITED | 19 nov. 1997 | 08 déc. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| THE PLACE OF TILLIEFOURE LIMITED | 19 nov. 1997 | 02 déc. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| HEMANI VENTURES LTD | 25 avr. 1997 | 19 nov. 1997 | Active | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| MAGGIE PENNY TRAINING LIMITED | 09 oct. 1997 | 24 oct. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| K-VENTURES LIMITED | 01 sept. 1997 | 01 oct. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| SHIRE HORSE MARKETING LIMITED | 14 févr. 1997 | 01 août 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 124 Rothwell Road Desborough NN14 2NT Northampton | British | ||
| KELICON LIMITED |