Bernard Alan RICKINSON
Personne physique
Titre | Dr |
---|---|
Prénom | Bernard |
Deuxième prénom | Alan |
Nom de famille | RICKINSON |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 1 |
Démissionné | 18 |
Total | 20 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREATIVE INTERFACES LIMITED | 01 avr. 2019 | Active | None | Administrateur | Creighton House 378 Lillie Road SW6 7PH London Studio 2 United Kingdom | England | British | |
INSTITUTE OF PACKAGING (SERVICES) LIMITED(THE) | 29 avr. 2008 | Dissoute | Chief Executive | Administrateur | 66 Burnthwaite Road SW6 5BG London | England | British | |
MATERIALS UK | 14 sept. 2010 | 19 juin 2019 | Active | Chief Executive | Administrateur | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
THE MATERIALS CYCLE AWARDING BODY LIMITED | 23 nov. 2017 | 31 déc. 2018 | Active | Chief Executive | Administrateur | Euston Road NW1 3AD London 297 | England | British |
PIABC LIMITED | 01 oct. 2016 | 31 déc. 2018 | Active | Ceo | Administrateur | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
SIGNATURE MATERIALS LIMITED | 03 oct. 2012 | 31 déc. 2018 | Active | Chief Executive | Administrateur | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
MATERIALS WORLD LTD | 16 oct. 2008 | 31 déc. 2018 | Active | Chief Executive | Administrateur | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
INSTITUTE OF PACKAGING (THE) | 29 avr. 2008 | 31 déc. 2018 | Active | Chief Executive | Administrateur | c/o Julija Bugajeva Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
MATERIALS UK | 08 mai 2006 | 31 déc. 2018 | Active | Secrétaire | Euston Road NW1 3AD London 297 England | British | ||
IOM COMMUNICATIONS LIMITED | 22 avr. 1998 | 31 déc. 2018 | Active | Chief Executive | Administrateur | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
MATERIALS INSTITUTE SERVICES LIMITED | 29 oct. 1997 | 31 déc. 2018 | Active | Chief Executive | Administrateur | Euston Road NW1 3AD London 297 England | England | British |
MATERIALS PROCESSING INSTITUTE | 29 avr. 2016 | 21 déc. 2018 | Active | Chief Executive | Administrateur | 297 Euston Road NW1 3AQ London The Institute Of Materials, Minerals And Mining United Kingdom | England | British |
CETMAN | 30 janv. 2006 | 31 juil. 2012 | Dissoute | Chief Executive | Administrateur | 66 Burnthwaite Road SW6 5BG London | England | British |
MATERIALS UK | 08 mai 2006 | 19 déc. 2006 | Active | Chief Executive | Administrateur | 66 Burnthwaite Road SW6 5BG London | England | British |
BODYCOTE PLC | 01 avr. 1998 | 28 mai 2003 | Active | Managing Director | Administrateur | 66 Burnthwaite Road SW6 5BG London | England | British |
BODYCOTE H.I.P. LIMITED | 01 avr. 1998 | Active | Managing Director | Administrateur | Normanhurst Ashford Road DE45 1GL Bakewell Derbyshire | British | ||
BODYCOTE PLC | 02 janv. 1996 | 31 mars 1997 | Active | Director | Administrateur | Normanhurst Ashford Road DE45 1GL Bakewell Derbyshire | British | |
BODYCOTE NOMINEES NO. 1 LIMITED | 01 avr. 1993 | 31 mars 1997 | Active | Company Director | Administrateur | Normanhurst Ashford Road DE45 1GL Bakewell Derbyshire | British | |
BODYCOTE METAL TECHNOLOGY LIMITED | 01 janv. 1997 | 31 mars 1997 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Normanhurst Ashford Road DE45 1GL Bakewell Derbyshire | British | |
BODYCOTE HEAT TREATMENTS LIMITED | 01 janv. 1997 | Active | Managing Director | Administrateur | Normanhurst Ashford Road DE45 1GL Bakewell Derbyshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0