Judith Mary MADDOCK
Personne physique
Titre | Mrs |
---|---|
Prénom | Judith |
Deuxième prénom | Mary |
Nom de famille | MADDOCK |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 7 |
Démissionné | 23 |
Total | 31 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEATH RESEARCH LTD | 09 juin 2015 | Active | Director | Administrateur | Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet 49 Hampshire United Kingdom | England | British | |
MAXSTIM PRODUCTS LTD | 06 mars 2013 | Dissoute | Finance Director | Administrateur | Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet 49 Hampshire United Kingdom | England | British | |
ZERO TO LANDFILL LTD | 18 nov. 2010 | Dissoute | Director | Administrateur | South Cornelly CF33 4RB Pyle Grove Quarry Bridgend Wales | England | British | |
RECYCLEITDOT.COM LIMITED | 21 mai 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet 49 Hampshire | England | British | |
PAPERSHRED LIMITED | 05 août 2008 | Dissoute | Finance Director | Administrateur | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | England | British | |
PAPERSHRED LIMITED | 05 août 2008 | Dissoute | Finance Director | Secrétaire | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | British | ||
THE RECYCLING COMPANY GB LTD. | 27 févr. 2008 | Dissoute | Finance Director | Secrétaire | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | British | ||
THE RECYCLING COMPANY GB LTD. | 27 févr. 2008 | Dissoute | Finance Director | Administrateur | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | England | British | |
GREENMAN PLANT CARE LTD | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2022 | Active | Finance Director | Administrateur | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | England | British |
MEDSA DEVELOPMENT LTD | 17 févr. 2016 | 31 déc. 2022 | Active | Finance Director | Administrateur | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | England | British |
MAXSTIM LIMITED | 28 mai 2013 | 31 déc. 2022 | Active | Finance Director | Administrateur | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | England | British |
MEDSA ANIMAL HEALTH LTD | 04 déc. 2007 | 31 déc. 2022 | Active | Director | Administrateur | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | England | British |
MEDSA RESEARCH LTD | 11 déc. 2006 | 31 déc. 2022 | Active | Finance Director | Administrateur | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | England | British |
SHIELD AUTOMOTIVE GREASED LIGHTNING UK LTD | 10 nov. 2006 | 31 déc. 2022 | Active | Finance Director | Administrateur | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | England | British |
SHIELD AUTOMOTIVE GREASED LIGHTNING UK LTD | 10 nov. 2006 | 31 déc. 2022 | Active | Finance Director | Secrétaire | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | British | |
CONTAMINATION CONTROL LTD | 12 avr. 2006 | 31 déc. 2022 | Active | Secrétaire | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | British | ||
CONTAMINATION CONTROL LTD | 12 avr. 2006 | 31 déc. 2022 | Active | Finance Director | Administrateur | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | England | British |
GREASED LIGHTNING LTD | 28 févr. 2006 | 31 déc. 2022 | Active | Finance Director | Secrétaire | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | British | |
GREASED LIGHTNING LTD | 28 févr. 2006 | 31 déc. 2022 | Active | Finance Director | Administrateur | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | England | British |
MEDSA GROUP LIMITED | 20 janv. 2006 | 31 déc. 2022 | Active | Accountant | Administrateur | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | England | British |
MEDSA GROUP LIMITED | 20 janv. 2006 | 31 déc. 2022 | Active | Accountant | Secrétaire | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | British | |
MEDSA RESEARCH LTD | 02 mai 2003 | 31 déc. 2022 | Active | Secrétaire | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | British | ||
MEDSA ANIMAL HEALTH LTD | 23 sept. 2002 | 31 déc. 2022 | Active | Secrétaire | Elm House Tanshire Park GU8 6LB Elstead Suite H1 Surrey England | British | ||
DTR MEDICAL LIMITED | 01 janv. 2006 | 11 oct. 2019 | Active | Accountant | Administrateur | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | England | British |
DTR MEDICAL LIMITED | 30 juil. 2002 | 11 oct. 2019 | Active | Secrétaire | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | British | ||
STERISHIELD SYSTEMS LIMITED | 01 oct. 2004 | 15 juin 2006 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | British | ||
SHIELD SALVAGE ASSOCIATES LIMITED | 26 mars 2004 | 15 juin 2006 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | British | ||
SHIELD MEDICARE LIMITED | 27 sept. 2004 | 15 juin 2006 | Liquidation | Secrétaire | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | British | ||
SHIELD HOLDINGS LIMITED | 25 mars 2004 | 15 juin 2006 | Liquidation | Accountant | Secrétaire | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | British | |
P.L. DRAKE (BUSINESS EQUIPMENT) LIMITED | 29 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | British | |||
THE SCORES HOTEL LIMITED | 07 juil. 1992 | 30 nov. 1999 | Liquidation | Secrétaire | 49 Dinorben Avenue GU52 7SQ Fleet Hampshire England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0