Anthony Stanley FOSSEY
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Anthony |
Deuxième prénom | Stanley |
Nom de famille | FOSSEY |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 2 |
Inactif | 4 |
Démissionné | 8 |
Total | 14 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASC WELLBEING LIMITED | 11 juin 2024 | Active | Retired | Administrateur | Ensign Business Centre Westwood Way CV4 8JA Coventry 12 West Midlands England | England | British | |
COVENTRY RESOURCE CENTRE FOR THE BLIND | 01 juin 2020 | Active | Accountant | Administrateur | Earlsdon Avenue South Earlsdon CV5 6TH Coventry 33 West Midlands | England | British | |
MASTWOOD LIMITED | 18 févr. 2019 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Priors Meadow CV47 1GE Southam 14 United Kingdom | England | British | |
WARWICKSHIRE HOME CARE SERVICES LIMITED | 04 juil. 2011 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Newlands Whites Row CV8 1HW Kenilworth Head Office First Floor Warwickshire | England | British | |
WARWICKSHIRE RESIDENTIAL CARE SERVICES LIMITED | 04 juil. 2011 | Dissoute | Accountant | Administrateur | First Floor, Newlands Whites Row CV8 1HW Kenilworth Head Office Warwickshire | England | British | |
WARWICKSHIRE FUEL AND POWER COMPANY LIMITED | 04 juil. 2011 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Newlands Whites Row CV8 1HW Kenilworth Head Office 1st Floor Warwickshire | England | British | |
LMC AUTOMOTIVE LIMITED | 01 janv. 2016 | 31 janv. 2019 | Active | Finance Director | Administrateur | Floor Clarendon House 52 Cornmarket Street OX1 3HJ Oxford 4th | England | British |
LMC INTERNATIONAL LIMITED | 01 janv. 2016 | 31 janv. 2019 | Active | Finance Director | Administrateur | Cornmarket Street OX1 3HJ Oxford 52 Cornmarket Street England | England | British |
LMC TYRE & RUBBER LIMITED | 21 mars 2018 | 31 janv. 2019 | Dissoute | Director | Administrateur | 52 Cornmarket Street OX1 3HJ Oxford 4th Floor Clarendon House United Kingdom | England | British |
LMCI HOLDINGS LIMITED | 09 mars 2018 | 31 janv. 2019 | Dissoute | Director | Administrateur | 52 Cornmarket Street OX1 3HJ Oxford 4th Floor, Clarendon House United Kingdom | England | British |
LMCA HOLDINGS LIMITED | 09 mars 2018 | 31 janv. 2019 | Dissoute | Director | Administrateur | 52 Cornmarket Street OX1 3HJ Oxford 4th Floor, Clarendon House United Kingdom | England | British |
LMC OXFORD HOLDINGS LIMITED | 01 janv. 2016 | 31 janv. 2019 | Dissoute | Finance Director | Administrateur | Floor Clarendon House Cornmarket Street OX1 3HJ Oxford 4th | England | British |
COMMON LANE DEVELOPMENTS LIMITED | 22 mai 2013 | 18 août 2017 | Active | Commercial And Finance Director | Administrateur | Floor Newlands Whites Row CV8 1HW Kenilworth 1st Warwickshire England | England | British |
WCS CARE GROUP LIMITED | 08 sept. 2008 | 18 août 2017 | Active | Commercial And Finance Director | Administrateur | Floor Newlands Whites Row CV8 1HW Kenilworth Head Office, 1st Warwickshire | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0