Derek BURNINGHAM
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Derek |
| Nom de famille | BURNINGHAM |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 1 |
| Démissionné | 83 |
| Total | 85 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE SERLO CONSORT LIMITED | 01 mai 2007 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | ||
| LIONCOURT PLC | 31 janv. 1994 | Liquidation | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | |||
| NOVAR (TWYFORDS) LIMITED | 19 mai 1998 | 30 sept. 2005 | Liquidation | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| UOP PRODUCTS UK LIMITED | 15 déc. 1995 | 21 sept. 2005 | Active | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| NOVAR NOMINEES LIMITED | 15 déc. 1995 | 21 sept. 2005 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| RALLIP HOLDINGS LIMITED | 15 déc. 1995 | 21 sept. 2005 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| SUTAX LIMITED | 19 oct. 1995 | 21 sept. 2005 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| NOVAR LIMITED | 17 oct. 1994 | 21 sept. 2005 | Active | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| NOVAR (TWYFORDS) LIMITED | 11 avr. 2003 | 01 sept. 2005 | Liquidation | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED | 11 avr. 2003 | 31 juil. 2005 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| CARADON PLC | 11 avr. 2003 | 31 juil. 2005 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| CHLORIDE SAFETY SYSTEMS LIMITED | 31 oct. 2001 | 31 juil. 2005 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| MB GROUP LIMITED | 09 avr. 2001 | 31 juil. 2005 | Active | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| CARADON UK DOORS & WINDOWS HOLDINGS LIMITED | 30 sept. 1997 | 31 juil. 2005 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| NOVAR PROPERTIES LIMITED | 25 mai 1995 | 31 juil. 2005 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| LEVITON MANUFACTURING UK LIMITED | 01 mars 2004 | 30 juin 2005 | Active | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| MB GROUP LIMITED | 11 avr. 2003 | 30 juin 2005 | Active | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| NOVAR SYSTEMS LIMITED | 11 avr. 2003 | 30 juin 2005 | Active | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| NOVAR PROJECTS LIMITED | 11 avr. 2003 | 30 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| CARADON UK DOORS & WINDOWS HOLDINGS LIMITED | 11 avr. 2003 | 30 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| EGA (2015) LIMITED | 11 avr. 2003 | 30 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| GILFLEX LIMITED | 11 avr. 2003 | 30 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| SUTAX LIMITED | 11 avr. 2003 | 30 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| NOVAR BUILDING PRODUCTS LIMITED | 11 avr. 2003 | 30 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| CARADON PLC | 11 avr. 2003 | 30 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| ACKERMANN LIMITED | 10 déc. 2001 | 30 juin 2005 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| NOVAR PROPERTIES LIMITED | 01 févr. 1995 | 30 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| HONEYWELL UK HEALTHCARE PLAN LIMITED | 11 avr. 2003 | 21 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| NOVAR PENSION TRUSTEES (NO.2) LIMITED | 11 avr. 2003 | 21 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| M.K. ELECTRIC TRUSTEES LIMITED | 11 avr. 2003 | 21 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| RESIDEO PLUMBING LIMITED | 11 avr. 2003 | 29 juin 2004 | Active | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| RESIDEO PLUMBING LIMITED | 29 déc. 2000 | 29 juin 2004 | Active | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| CARADON JONES LIMITED | 30 avr. 1998 | 29 juin 2004 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British | |
| CARADON JONES LIMITED | 01 janv. 1997 | 29 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | ||
| NOVAR PROJECTS LIMITED | 15 févr. 1997 | 31 juil. 2001 | Dissoute | Administrateur | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0