Maxwell Jonathan SCOTT
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Maxwell |
Deuxième prénom | Jonathan |
Nom de famille | SCOTT |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 9 |
Inactif | 7 |
Démissionné | 14 |
Total | 30 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONDON BRASSERIES HOLDINGS LTD | 26 oct. 2023 | Active | Accountant | Administrateur | Shelton Street Covent Garden WC2H 9JQ London 71-75 United Kingdom | United Kingdom | British | |
LONDON BRASSERIES MANAGEMENT LTD | 04 oct. 2020 | Active | Accountant | Administrateur | Covent Garden WC2H 9JQ London 71-75 Shelton Street United Kingdom | United Kingdom | British | |
PIAZZA BRASSERIE LTD | 25 sept. 2020 | Active | Accountant | Administrateur | Covent Garden WC2H 9JQ London 71-75 Shelton Street United Kingdom | United Kingdom | British | |
CHELSEA BRASSERIE LTD | 18 août 2020 | Active | Accountant | Administrateur | Covent Garden WC2H 9JQ London 71-75 Shelton Street United Kingdom | United Kingdom | British | |
PALM COURT BRASSERIE LTD | 23 juil. 2020 | Active | Accountant | Administrateur | Covent Garden WC2H 9JQ London 71-75 Shelton Street United Kingdom | United Kingdom | British | |
OLD COMPTON BRASSERIE LTD | 19 juil. 2020 | Active | Accountant | Administrateur | Covent Garden WC2H 9JQ London 71-75 Shelton Street United Kingdom | United Kingdom | British | |
LONDON BRASSERIES LTD | 14 juil. 2020 | Active | Accountant | Administrateur | Covent Garden WC2H 9JQ London 71-75 Shelton Street United Kingdom | United Kingdom | British | |
MAXACCS LIMITED | 12 juin 2017 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Stamford House United Kingdom | United Kingdom | British | |
CCMF PIANO LIMITED | 08 mai 2017 | Active | Accountant | Administrateur | Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Stamford House England | United Kingdom | British | |
SEEBEEDEE LTD | 06 sept. 2016 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Stamford House | United Kingdom | British | |
KILVINTON LLP | 01 juin 2016 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Stamford House Gloucestershire | United Kingdom | |||
METISTORE LIMITED | 14 juil. 2014 | Liquidation | Director | Administrateur | Wentworth House 122 New Road Side LS18 4QB Horsforth Leeds C/O Live Recoveries | United Kingdom | British | |
STAMSTORE LLP | 16 nov. 2010 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Stamford House Glos England | United Kingdom | |||
PEREFALK LIMITED | 18 févr. 2003 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | Stamford House Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Gloucestershire | British | ||
ATHERSTORE LIMITED | 07 sept. 1999 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | Stamford House Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Gloucestershire | British | ||
ATHERSTORE LIMITED | 07 sept. 1999 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Stamford House Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Gloucestershire | United Kingdom | British | |
STICKY FINGERS RESTAURANT LIMITED | 05 août 2001 | 15 oct. 2019 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Stamford House Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Gloucestershire | British | |
BILL AND BRIAN LTD. | 14 sept. 2000 | 15 oct. 2019 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | Stamford House Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Gloucestershire | British | |
NYC BARS & RESTAURANTS LIMITED | 07 août 1997 | 15 oct. 2019 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Stamford House Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Gloucestershire | British | |
MAXWELLS RESTAURANTS (1994) LIMITED | 17 déc. 1993 | 15 oct. 2019 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | Stamford House Leysbourne GL55 6AD Chipping Campden Gloucestershire | British | |
BRAHMS AND LISZT (WINE BARS) LIMITED | 15 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 22 Henrietta Street London WC2E 8ND | British | |||
MAXWELLS RESTAURANTS LIMITED | 23 nov. 2000 | 15 oct. 2019 | Liquidation | Secrétaire | 22 Henrietta Street London WC2E 8ND | British | ||
PEREFALK LIMITED | 18 févr. 2003 | 31 oct. 2003 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Mudhall Barn Todenham GL56 9PN Moreton In Marsh Gloucestershire | British | |
EDMONPLAN LIMITED | 07 sept. 1999 | 31 oct. 2002 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | Mudhall Barn Todenham GL56 9PN Moreton In Marsh Gloucestershire | British | |
EDMONPLAN LIMITED | 07 sept. 1999 | 01 mai 2001 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Mudhall Barn Todenham GL56 9PN Moreton In Marsh Gloucestershire | British | |
MAXWELLS RESTAURANTS LIMITED | 07 août 2000 | 23 oct. 2000 | Liquidation | Accountant | Administrateur | Mudhall Barn Todenham GL56 9PN Moreton In Marsh Gloucestershire | British | |
BILL AND BRIAN LTD. | 07 août 2000 | 30 sept. 2000 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Mudhall Barn Todenham GL56 9PN Moreton In Marsh Gloucestershire | British | |
BILL AND BRIAN LTD. | 12 mai 2000 | 07 août 2000 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | Mudhall Barn Todenham GL56 9PN Moreton In Marsh Gloucestershire | British | |
MAXWELLS RESTAURANTS LIMITED | 07 août 2000 | Liquidation | Secrétaire | Mudhall Barn Todenham GL56 9PN Moreton In Marsh Gloucestershire | British | |||
MAXWELLS RESTAURANTS (1994) LIMITED | 17 déc. 1993 | 10 févr. 1994 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Flat 7 36 Campden Hill Gardens W8 7AZ London | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0