Gary David BELL
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Gary |
Deuxième prénom | David |
Nom de famille | BELL |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 8 |
Démissionné | 15 |
Total | 24 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCH-LTGS GB LIMITED | 10 févr. 2015 | Active | Managing Director | Administrateur | 23 Stourton Road LS29 9BG Ilkley 23 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
BU-DEL FOODS LIMITED | 18 mai 2007 | Dissoute | Director | Administrateur | Limekiln House Arthington Lane LS21 1JZ Pool In Wharfedale | United Kingdom | British | |
ROSEDYNE FOODSERVICE LIMITED | 06 juil. 2001 | Dissoute | Managing Director | Administrateur | Limekiln House Arthington Lane LS21 1JZ Pool In Wharfedale | United Kingdom | British | |
P.J.M. CHILLED FOODS LIMITED | 06 juil. 2001 | Dissoute | Managing Director | Administrateur | Limekiln House Arthington Lane LS21 1JZ Pool In Wharfedale | United Kingdom | British | |
GWECO 149 LIMITED | 05 juil. 2001 | Dissoute | Director | Administrateur | Limekiln House Arthington Lane LS21 1JZ Pool In Wharfedale | United Kingdom | British | |
AFFINITY FOOD MARKETING LIMITED | 05 juil. 2001 | Dissoute | Managing Director | Administrateur | Limekiln House Arthington Lane LS21 1JZ Pool In Wharfedale | United Kingdom | British | |
AFFINITY FOOD HOLDINGS LIMITED | 25 juin 2001 | Dissoute | Managing Director | Administrateur | Limekiln House Arthington Lane LS21 1JZ Pool In Wharfedale | United Kingdom | British | |
DELICATESSEN HAMPERS LIMITED | Dissoute | Company Director | Administrateur | Limekiln House Arthington Lane LS21 1JZ Pool In Wharfedale | United Kingdom | British | ||
DELICATESSEN HAMPERS LIMITED | Dissoute | Secrétaire | Limekiln House Arthington Lane LS21 1JZ Pool In Wharfedale | British | ||||
THE FINANCIAL ADVICE SERVICE LIMITED | 09 juin 2014 | 22 nov. 2018 | Active | Managing Director | Administrateur | Victoria Road Kirkstall LS5 3JB Leeds First Floor, Chantry House West Yorkshire England | United Kingdom | British |
TORIGA ENERGY LIMITED | 02 févr. 2012 | 24 févr. 2014 | Active | Managing Director | Administrateur | Arthington Lane Pool In Wharfedale LS21 1JZ Otley Limekiln House West Yorkshire Uk | United Kingdom | British |
FRESHFAYRE LIMITED | 24 déc. 2009 | Dissoute | Managing Director | Administrateur | Limekiln House Arthington Lane LS21 1JZ Pool In Wharfedale | United Kingdom | British | |
MOBILI FURNITURE LIMITED | 04 nov. 2005 | 30 juin 2007 | Dissoute | Director | Administrateur | Limekiln House Arthington Lane LS21 1JZ Pool In Wharfedale | United Kingdom | British |
ROSEDYNE FOODSERVICE LIMITED | 06 juil. 2001 | 06 mars 2002 | Dissoute | Managing Director | Secrétaire | 1 Hilton Mews Bramhope LS16 9LF Leeds West Yorkshire | British | |
P.J.M. CHILLED FOODS LIMITED | 06 juil. 2001 | 06 mars 2002 | Dissoute | Managing Director | Secrétaire | 1 Hilton Mews Bramhope LS16 9LF Leeds West Yorkshire | British | |
AFFINITY FOOD MARKETING LIMITED | 05 juil. 2001 | 06 mars 2002 | Dissoute | Managing Director | Secrétaire | 1 Hilton Mews Bramhope LS16 9LF Leeds West Yorkshire | British | |
GWECO 149 LIMITED | 05 juil. 2001 | 06 mars 2002 | Dissoute | Director | Secrétaire | 1 Hilton Mews Bramhope LS16 9LF Leeds West Yorkshire | British | |
AFFINITY FOOD HOLDINGS LIMITED | 25 juin 2001 | 06 mars 2002 | Dissoute | Managing Director | Secrétaire | 1 Hilton Mews Bramhope LS16 9LF Leeds West Yorkshire | British | |
FRESHFAYRE LIMITED | 14 févr. 2001 | 06 mars 2002 | Dissoute | Managing Director | Secrétaire | 1 Hilton Mews Bramhope LS16 9LF Leeds West Yorkshire | British | |
FRESHFAYRE LIMITED | 01 nov. 1999 | 20 oct. 2000 | Dissoute | Managing Director | Secrétaire | 1 Hilton Mews Bramhope LS16 9LF Leeds West Yorkshire | British | |
S.K. CHILLED FOODS LIMITED | 08 sept. 2000 | Active | Manager | Administrateur | 8 Chestnut Way LS16 7TN Leeds West Yorkshire | British | ||
S.K. CHILLED FOODS LIMITED | 19 déc. 1996 | 10 févr. 1999 | Active | Secrétaire | 26 Langtons Wharf LS2 7EF Leeds West Yorkshire | British | ||
NEWMAN SCOTT LIMITED | 17 mars 1993 | Liquidation | Secrétaire | 7 Hill Top View Tingley WF3 1HR Wakefield West Yorkshire | British | |||
NEWMAN SCOTT LIMITED | 17 mars 1993 | Liquidation | Company Director | Administrateur | 7 Hill Top View Tingley WF3 1HR Wakefield West Yorkshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0