Andrew James FROUD
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Andrew |
| Deuxième prénom | James |
| Nom de famille | FROUD |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 3 |
| Démissionné | 22 |
| Total | 26 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY PERFECT COLLAGEN LIMITED | 11 sept. 2015 | Dissoute | Administrateur | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire | England | British | ||
| ALICSUR UK LIMITED | 19 juil. 2013 | Dissoute | Administrateur | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire England | United Kingdom | British | ||
| PALMER CLARK LIMITED | 29 mars 2004 | Dissoute | Secrétaire | Mulberry House Brook Lane CV37 8UA Newbold On Stour Warwickshire | British | |||
| RLF PROPERTIES LIMITED | 11 févr. 1999 | Active | Administrateur | Bishopton Lane Bishopton CV37 9QY Stratford-Upon-Avon Bruce Lodge England | England | British | ||
| PALMER CLARK LIMITED | 30 sept. 2015 | 01 oct. 2020 | Active | Administrateur | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire | England | British | |
| MFA 3 LIMITED | 01 oct. 2016 | 30 sept. 2020 | Active | Administrateur | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 United Kingdom | England | British | |
| MULBERRY FROUD ASSOCIATES LIMITED | 17 janv. 2011 | 30 sept. 2020 | Active | Administrateur | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire England | United Kingdom | British | |
| MULBERRY PORTFOLIOS LIMITED | 01 mai 2010 | 30 sept. 2020 | Dissoute | Administrateur | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire England | United Kingdom | British | |
| SKYVAPES LTD | 08 avr. 2015 | 18 août 2020 | Dissoute | Administrateur | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire | England | British | |
| COSMEDIC SURGICAL LIMITED | 07 déc. 2015 | 08 mai 2019 | Dissoute | Administrateur | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire | England | British | |
| JOHN CRONIN SALES LIMITED | 07 sept. 2017 | 01 oct. 2017 | Dissoute | Administrateur | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire | England | British | |
| JOHN CRONIN SALES LIMITED | 04 nov. 2015 | 01 juil. 2016 | Dissoute | Administrateur | Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa 51 Warwickshire England | England | British | |
| THE SUSAN HERBERT PORTFOLIO LIMITED | 17 juil. 2013 | 01 nov. 2013 | Active | Administrateur | Mulberry House Brook Lane CV37 8UA Newbold On Stour The Studio Warwickshire | United Kingdom | British | |
| COTSWOLD FUDGE CO. LIMITED | 12 mars 2008 | 15 mai 2012 | Active | Administrateur | Mulberry House Brook Lane CV37 8UA Newbold On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | |
| PALMER CLARK LIMITED | 11 janv. 2011 | 31 janv. 2011 | Dissoute | Administrateur | The Chapel Chapel Lane Newbold On Stour CV37 8TY Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | |
| MULBERRY PORTFOLIOS LIMITED | 12 juin 2009 | 01 déc. 2009 | Dissoute | Administrateur | Mulberry House Brook Lane CV37 8UA Newbold On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | |
| RETAIL ELITE LTD | 09 nov. 2007 | 01 sept. 2009 | Dissoute | Administrateur | Mulberry House Brook Lane CV37 8UA Newbold On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | |
| CHRIS FORMAN LIMITED | 01 oct. 2004 | 01 sept. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| EUROPEAN RETAIL ENGINEERING LIMITED | 16 oct. 2001 | 28 févr. 2006 | Active | Administrateur | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| MFSF LIMITED | 01 sept. 2003 | 23 août 2005 | Active | Administrateur | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| SUSSEX HOUSE (GLENILLA ROAD) LIMITED | 04 mars 2003 | 31 mars 2005 | Active | Secrétaire | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| INSPECTION LINK LIMITED | 01 nov. 2001 | 17 sept. 2004 | Dissoute | Secrétaire | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| FOUR CORNERS TRADING COMPANY LIMITED | 02 janv. 2001 | 01 oct. 2003 | Liquidation | Secrétaire | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| KEYSTROKE TYPESETTING & GRAPHIC DESIGN LIMITED | 02 janv. 2002 | 15 mai 2003 | Dissoute | Secrétaire | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| QUADRACO LIMITED | 18 nov. 2001 | 21 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British | ||
| INSPECTION LINK LIMITED | 03 oct. 2000 | 01 nov. 2001 | Dissoute | Administrateur | Fintree House Rookery Lane CV37 8TZ Newbold On Stour Warwickshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0