Derek Arthur STUBBS
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Derek |
| Deuxième prénom | Arthur |
| Nom de famille | STUBBS |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 3 |
| Démissionné | 14 |
| Total | 18 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHINSTONE MEWS RTM COMPANY LIMITED | 19 sept. 2018 | Active | Administrateur | Park View NE26 3QR Whitley Bay 220 England | France | British | ||
| TRADE FILMS LIMITED | 16 déc. 2004 | Dissoute | Administrateur | Kings Road BN1 2JH Brighton 26 Cavendish House England | France | British | ||
| THE LYNDHURST PARTNERSHIP LIMITED | 21 oct. 2002 | Dissoute | Administrateur | Route D'Artix 34210 Beaufort 3 France | France | British | ||
| TRADE FILMS LIMITED | Dissoute | Secrétaire | Kings Road BN1 2JH Brighton 26 Cavendish House England | British | ||||
| HEADLINE PICTURES (PETER PAN) LIMITED | 18 juin 2014 | 30 sept. 2023 | Active | Administrateur | 31 King Street West M3 2PJ Manchester Reedham House Greater Manchester England | France | British | |
| HEADLINE PICTURES (KIN) LIMITED | 23 oct. 2012 | 30 sept. 2023 | Active | Administrateur | 31 King Street West M3 2PJ Manchester Reedham House Greater Manchester England | France | British | |
| HEADLINE PICTURES (INVISIBLE WOMAN) LIMITED | 25 juil. 2011 | 30 sept. 2023 | Active | Administrateur | 31 King Street West M3 2PJ Manchester Reedham House Greater Manchester England | France | British | |
| HEADLINE PICTURES (QUARTET) LIMITED | 16 juil. 2008 | 30 sept. 2023 | Active | Secrétaire | 31 King Street West M3 2PJ Manchester Reedham House Greater Manchester England | British | ||
| HEADLINE PICTURES (QUARTET) LIMITED | 16 juil. 2008 | 30 sept. 2023 | Active | Administrateur | 31 King Street West M3 2PJ Manchester Reedham House Greater Manchester England | France | British | |
| HEADLINE PICTURES (PAN IN SCARLET) LIMITED | 25 mars 2008 | 30 sept. 2023 | Active | Secrétaire | 31 King Street West M3 2PJ Manchester Reedham House Greater Manchester England | British | ||
| HEADLINE PICTURES (PAN IN SCARLET) LIMITED | 25 mars 2008 | 30 sept. 2023 | Active | Administrateur | 31 King Street West M3 2PJ Manchester Reedham House Greater Manchester England | France | British | |
| HEADLINE PICTURES LIMITED | 16 déc. 2004 | 30 sept. 2023 | Active | Administrateur | 31 King Street West M3 2PJ Manchester Reedham House Greater Manchester England | France | British | |
| HEADLINE PICTURES LIMITED | 11 août 1995 | 30 sept. 2023 | Active | Secrétaire | 31 King Street West M3 2PJ Manchester Reedham House Greater Manchester England | British | ||
| SAUL'S STORY LIMITED | 30 mai 2001 | 20 avr. 2020 | Dissoute | Secrétaire | Route D'Artix 34210 Beaufort 3 France | British | ||
| NORTHERN REGION FILM AND TELEVISION ARCHIVE | 19 janv. 2005 | 22 janv. 2013 | Dissoute | Administrateur | 29 Lyndhurst Avenue Jesmond NE2 3LJ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | |
| SAUL'S STORY LIMITED | 30 mai 2001 | 31 mai 2004 | Dissoute | Administrateur | 29 Lyndhurst Avenue Jesmond NE2 3LJ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | |
| HEADLINE PICTURES LIMITED | 11 août 1995 | 31 mai 2004 | Active | Administrateur | 29 Lyndhurst Avenue Jesmond NE2 3LJ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | |
| TRADE FILMS LIMITED | 31 mai 2004 | Dissoute | Administrateur | 29 Lyndhurst Avenue Jesmond NE2 3LJ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0