Benjamin Jamie SPENCER
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Benjamin |
Deuxième prénom | Jamie |
Nom de famille | SPENCER |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 12 |
Inactif | 5 |
Démissionné | 6 |
Total | 23 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS8 HOLDCO LIMITED | 03 août 2022 | Active | Property Developer | Administrateur | Ballards Lane N3 1XW London 35 United Kingdom | Portugal | British | |
GS8 ACTON LIMITED | 29 déc. 2020 | Active | Property Developer | Administrateur | Ballards Lane N3 1XW London 35 England | Portugal | British | |
GS8 BASILDON LIMITED | 22 avr. 2020 | Active | Company Director | Administrateur | Hampstead High Street NW3 1PR London 6a United Kingdom | Portugal | British | |
B&B VENTURE CAPITAL LTD | 30 mai 2019 | Dissoute | None Supplied | Administrateur | 75 Maygrove Road West Hampstead NW6 2EG London C/O Goldwins Limited United Kingdom | United Kingdom | British | |
GS8 WATFORD LIMITED | 07 déc. 2017 | Active | Director | Administrateur | 25 Mandela Street NW1 0DU London The Lodge England England | Portugal | British | |
ARBORETUM EPPING DEVELOPMENTS LIMITED | 26 avr. 2017 | Active | Director | Administrateur | Bedford Square WC1B 3HH London 21 United Kingdom | Portugal | British | |
GS8 INVESTMENTS LTD | 20 janv. 2017 | Active | Director | Administrateur | 25 Mandela Street NW1 0DU London The Lodge England England | Portugal | British | |
GS8 EAST LONDON LIMITED | 21 nov. 2016 | Dissoute | Property Developer | Administrateur | Heath Street NW3 6SS London 99 United Kingdom | United Kingdom | British | |
GS8 STRATFORD LLP | 16 nov. 2016 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Heath Street NW3 6SS London 99 United Kingdom | United Kingdom | |||
WATFORD DEVELOPMENTS LIMITED | 17 oct. 2016 | Liquidation | Property Developer | Administrateur | 25 Mandela Street NW1 0DU London The Lodge England England | Portugal | British | |
GS8 PROJECTS LIMITED | 07 oct. 2016 | Active | Director | Administrateur | 25 Mandela Street NW1 0DU London The Lodge England England | Portugal | British | |
ORFORD ROAD INDUSTRIAL LIMITED | 28 sept. 2016 | Active | Property Developer | Administrateur | 25 Mandela Street NW1 0DU London The Lodge England England | Portugal | British | |
FOREST GATE INVESTMENTS LLP | 01 avr. 2016 | Active | Membre désigné de la LLP | Hampstead High Street NW3 1PR London 6a England | England | |||
EPPING HIGH STREET LIMITED | 10 août 2015 | Active | Property Developer | Administrateur | 25 Mandela Street NW1 0DU London The Lodge England England | Portugal | British | |
GS8 DEVELOPMENTS LIMITED | 04 mars 2015 | Dissoute | Property Developer | Administrateur | Heath Street NW3 6SS London 99 United Kingdom | Portugal | British | |
JLMT LIMITED | 15 janv. 2015 | Dissoute | Property Developer | Administrateur | Heath Street NW3 6SS London 99 United Kingdom | United Kingdom | British | |
PULSO LIMITED | 26 oct. 2012 | Active | Property Development | Administrateur | c/o Tish Leibovitch Cranbrook Road IG1 4TG Ilford 249 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | |
GS8 HOMES LIMITED | 03 août 2022 | 01 nov. 2023 | Active | Property Developer | Administrateur | Ballards Lane N3 1XW London 35 United Kingdom | Portugal | British |
SYNC ENGINEERING LIMITED | 01 sept. 2020 | 08 mars 2021 | Dissoute | Director | Administrateur | Heath Street NW3 6SS London 99 England | Portugal | British |
GS8 CONSTRUCTION LIMITED | 03 déc. 2020 | 23 févr. 2021 | Liquidation | Property Developer | Administrateur | Heath Street NW3 6SS London 99 United Kingdom | United Kingdom | British |
C&C FOOD GROUP LIMITED | 25 mars 2020 | 01 févr. 2021 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Heath Street NW3 6SS London 99 England | Portugal | British |
KOMI APP LIMITED | 17 oct. 2019 | 23 sept. 2020 | Active | Property Developer | Administrateur | Heath Street NW3 6SS London 99 United Kingdom | United Kingdom | British |
CITIDWELL LTD | 22 juil. 2014 | 22 sept. 2014 | Active | Director | Administrateur | Spectrum House 32-34 Gordon House Road NW5 1LP London Unit 17 | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0