Stuart Leslie SEYMOUR
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Stuart |
Deuxième prénom | Leslie |
Nom de famille | SEYMOUR |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 33 |
Total | 33 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.J.G(MANAGEMENT)LIMITED | 05 mars 1996 | 18 févr. 2005 | Active | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
GLEESON SERVICES LIMITED | 05 mars 1996 | 18 févr. 2005 | Active | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
GLEESON HOUSING DEVELOPMENTS LIMITED | 05 mars 1996 | 18 févr. 2005 | Active | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
HAREDON DEVELOPMENTS LIMITED | 05 mars 1996 | 18 févr. 2005 | Active | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
GLEESON HOMES SOUTHERN LIMITED | 05 mars 1996 | 18 févr. 2005 | Active | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
GLEESON CLASSIC HOMES LIMITED | 05 mars 1996 | 18 févr. 2005 | Active | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
EDNA (BAMFORD MILL) LIMITED | 22 févr. 2001 | 18 févr. 2005 | Dissoute | Compnay Secretary | Administrateur | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
EDNA (BAMFORD MILL) LIMITED | 07 juil. 2000 | 18 févr. 2005 | Dissoute | Director | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
GLEESON HOMES (NORTH EAST) LIMITED | 22 déc. 1998 | 18 févr. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
CAVENDISH GLEESON SECOND LIMITED | 27 juin 1997 | 18 févr. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
CAVENDISH GLEESON CASH BACKED LIMITED | 27 juin 1997 | 18 févr. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
CAVENDISH GLEESON GUARANTEED LIMITED | 29 mai 1997 | 18 févr. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
M J GLEESON (PAYROLL SERVICES) LIMITED | 05 mars 1996 | 18 févr. 2005 | Dissoute | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
H.H.N.C.INVESTMENTS LIMITED | 05 mars 1996 | 18 févr. 2005 | Dissoute | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
ACORN HILL LIMITED | 27 juin 2000 | 20 janv. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
SMALLFIELDS MANAGEMENT LIMITED | 09 mai 1996 | 20 janv. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED | 05 mars 1996 | 26 sept. 2002 | Active | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
GLEESON HOMES (PE) LIMITED | 05 mars 1996 | 26 sept. 2002 | Dissoute | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
HOMES EXCHANGE LIMITED | 05 mars 1996 | 26 sept. 2002 | Dissoute | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
GLEESON REGENERATION LIMITED | 12 mars 2001 | 18 juil. 2002 | Active | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
COLROY LIMITED | 05 mars 1996 | 18 juil. 2002 | Active | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
GLEESON CONSTRUCTION SERVICES LIMITED | 05 mars 1996 | 01 juil. 2002 | Active | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
BECKETT PARK MANAGEMENT (NO.2) LIMITED | 09 mai 1996 | 17 juil. 2001 | Active | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
GLEESON PROPERTIES LIMITED | 05 mars 1996 | 20 juin 2001 | Active | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
G L PLANT (LEASING) LIMITED | 05 mars 1996 | 20 juin 2001 | Dissoute | Property Manager | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | |
ST JOHN'S MEWS LIMITED | 18 févr. 1997 | 09 nov. 1999 | Active | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
CEDARS COURT (BURPHAM) LIMITED | 04 nov. 1999 | Dissoute | Self Employed | Administrateur | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
ST. FRANCIS' GARDENS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 09 mai 1996 | 24 sept. 1998 | Active | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
SQUIRRELS REACH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01 avr. 1996 | 04 déc. 1997 | Active | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
THE PINES (SUTTON) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 09 mai 1996 | 24 déc. 1996 | Active | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
HAMBLEDON PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 09 mai 1996 | 13 déc. 1996 | Active | Secr étaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
CHANDON LODGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 09 mai 1996 | 02 sept. 1996 | Active | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | ||
BEAUFORT HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 09 mai 1996 | 07 août 1996 | Active | Secrétaire | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0