Patricia Jane COLLINS
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Patricia |
Deuxième prénom | Jane |
Nom de famille | COLLINS |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 2 |
Démissionné | 36 |
Total | 38 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DITA SUPPLIES LIMITED | 27 janv. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Lion House Oriental Road GU22 8AP Woking Surrey | British | |||
JAMES WALKER BRITCO LIMITED | 27 janv. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Lion House 147 Oriental Road GU22 8AP Woking Surrey | British | |||
JWPS TRUSTEES LIMITED | 13 févr. 2006 | 05 août 2020 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | Lion House, Oriental Road Woking GU22 8AP Surrey | England | British |
DEVOL CAST NYLON LIMITED | 02 juin 2008 | 31 août 2018 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Faulds Park Industrial Estate Faulds Park Road PA19 1FB Gourock Unit 2 Scotland | British | |
DEVOL FABRICATIONS LIMITED | 02 juin 2008 | 31 août 2018 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Faulds Park Industrial Estate Faulds Park Road PA19 1FB Gourock Unit 2 Scotland | British | |
DEVOL MOULDING SERVICES LIMITED | 02 juin 2008 | 31 août 2018 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Faulds Park Industrial Estate Faulds Park Road PA19 1FB Gourock Unit 2 Scotland | British | |
DEVOL ENGINEERING LIMITED | 02 juin 2008 | 31 août 2018 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Faulds Park Industrial Estate Faulds Park Road PA19 1FB Gourock Unit 2 Scotland | British | |
DEVOL BUSHING LIMITED | 02 juin 2008 | 31 août 2018 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Faulds Park Industrial Estate Faulds Park Road PA19 1FB Gourock Unit 2 Scotland | British | |
JWPS TRUSTEES LIMITED | 13 févr. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Lion House, Oriental Road Woking GU22 8AP Surrey | British | ||
JWSEMPP TRUSTEES LIMITED | 13 févr. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Oriental Road GU22 8AP Woking Lion House Surrey England | British | ||
PHOENIX ROLLERS(OTLEY)LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Oriental Road GU22 8AP Woking Lion House Surrey England | British | ||
JAMES WALKER GROUP LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Oriental Road GU22 8AP Woking 147 Surrey | British | ||
JAMES WALKER TRUSTEES LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Lion House Oriental Road GU22 8AP Woking Surrey | British | ||
JAMES WALKER TOWNSON LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Lion House, Oriental Road Woking GU22 8AP Surrey | British | ||
JAMES WALKER & CO. LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Oriental Road GU22 8AP Woking Lion House Surrey England | British | ||
JAMES WALKER NOMINEES LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Oriental Road GU22 8AP Woking Lion House Surrey England | British | ||
JAMES WALKER SEALING PRODUCTS & SERVICES LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Oriental Road GU22 8AP Woking Lion House Surrey England | British | ||
KEA-FLEX MOULDINGS LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Lion House, Oriental Road Woking GU22 8AP Surrey | British | ||
JAMES WALKER VICEROY LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Oriental Road GU22 8AP Woking Lion House Surrey England | British | ||
JAMES WALKER METAFLEX LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Oriental Road GU22 8AP Woking Lion House Surrey England | British | ||
JAMES WALKER ROTABOLT LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Lion House, Oriental Road Woking GU22 8AP Surrey | British | ||
TICO MANUFACTURING LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Lion House Oriental Road GU22 8AP Woking Surrey | British | ||
JAMES WALKER SEALS LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Lion House, Oriental Road Woking GU22 8AP Surrey | British | ||
JAMES WALKER MOORFLEX LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Lion House, Oriental Road Woking GU22 8AP Surrey | British | ||
TIFLEX LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Lion House Oriental Road GU22 8AP Woking Surrey | British | ||
JAMES WALKER ENGINEERING SERVICES LIMITED | 27 janv. 2006 | 31 août 2018 | Active | Secrétaire | Lion House, Oriental Road Woking GU22 8AP Surrey | British | ||
JWSEMPP TRUSTEES LIMITED | 13 févr. 2006 | 14 févr. 2007 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | 215 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 3QA Wokingham Berkshire | England | British |
JANUS HENDERSON SECRETARIAL SERVICES UK LIMITED | 27 févr. 1995 | 20 juin 1997 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | 215 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 3QA Wokingham Berkshire | England | British |
TURNKEY OPERATIONS LIMITED | 01 août 1995 | 24 déc. 1996 | Dissoute | Secrétaire | 215 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 3QA Wokingham Berkshire | British | ||
NORMAN HAY ENGINEERING LIMITED | 17 févr. 1995 | Active | Secrétaire | 215 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 3QA Wokingham Berkshire | British | |||
TURNKEY OPERATIONS LIMITED | 28 mai 1992 | 17 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire | 215 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 3QA Wokingham Berkshire | British | ||
NORMAN HAY ONE LIMITED | 31 mai 1990 | 17 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire | 215 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 3QA Wokingham Berkshire | British | ||
NORMAN HAY (METAL FINISHERS) LIMITED | 17 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire | 215 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 3QA Wokingham Berkshire | British | |||
POLLSHARE LIMITED | 17 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire | 215 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 3QA Wokingham Berkshire | British | |||
NORMAN HAY TWO LIMITED | 17 févr. 1995 | Dissoute | Secrétaire | 215 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 3QA Wokingham Berkshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0