David William GREEN
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | David |
Deuxième prénom | William |
Nom de famille | GREEN |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 2 |
Inactif | 2 |
Démissionné | 16 |
Total | 20 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF LANDSCAPE LIMITED | 02 avr. 2007 | Active | Secrétaire | 2 Chichester Street OL16 2AX Rochdale Chichester House Lancashire England | British | |||
STRATEGIC GOLF PARTNERSHIP LIMITED | 02 avr. 2007 | Active | Secrétaire | Links Road Lostock BL6 4AF Bolton Regent Park Golf Course England | British | |||
ALTEX AGENCIES LIMITED | 28 avr. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | |||
LAM CONNECT INTERNATIONAL LIMITED | 28 févr. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | |||
SG WINDOW SYSTEMS LIMITED | 09 juin 2004 | 09 juin 2023 | Active | Secrétaire | Longacre Bamber Bridge PR5 8HE Preston 76 England | British | ||
ATHERTON PRE-SCHOOL DAY CARE LIMITED | 26 sept. 2006 | 01 sept. 2016 | Active | Company Director | Administrateur | Ashberry House, 41 New Hall Lane Heaton BL1 5LW Bolton Lancs | England | British |
ATHERTON PRE-SCHOOL DAY CARE LIMITED | 26 sept. 2006 | 01 sept. 2016 | Active | Company Director | Secrétaire | Longacre Bamber Bridge PR5 8HE Preston 76 England | British | |
OPEN GOLF AND LEISURE LIMITED | 01 sept. 2002 | 16 mai 2016 | Active | Accountant | Secrétaire | 41 New Hall Lane BL1 5LW Bolton Ashberry House Lancsashire United Kingdom | British | |
REGENT PARK GOLF COURSE LIMITED | 01 sept. 2002 | 16 mai 2016 | Active | Accountant | Secrétaire | Regent Park Golf Course Links Road, Lostock BL6 4AF Bolton Lancashire | British | |
INDEPENDENT MEDICAL EVIDENCE LIMITED | 06 déc. 2005 | 30 nov. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | ||
BRADLEY FOLD TRAVEL LIMITED | 30 juin 2007 | 31 oct. 2010 | Active | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | ||
NORTHWEST TRADE PRINTERS LIMITED | 23 févr. 2007 | 14 août 2009 | Dissoute | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | ||
APS HEATING (GAS SERVICES) LIMITED | 10 août 1995 | 28 mars 1997 | Dissoute | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | ||
AVONSIDE PLUMBING & HEATING (NORTH EAST) LTD | 01 oct. 1994 | 28 mars 1997 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | |
WINDOW SYSTEMS LIMITED | 01 oct. 1994 | 28 mars 1997 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | |
AVONSIDE PLUMBING & HEATING (YORKSHIRE) LTD | 01 oct. 1994 | 28 mars 1997 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | |
AVONSIDE PLUMBING & HEATING (NORTH WEST) LIMITED | 01 oct. 1994 | 28 mars 1997 | Active | Accoutant | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | |
JOSHUA AND TOM TAYLOR LIMITED | 01 oct. 1994 | 28 mars 1997 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | |
AVONSIDE CONTRACT SERVICES LIMITED | 01 mai 1994 | 28 mars 1997 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | |
AVONSIDE CONTRACT SERVICES LIMITED | 01 mai 1994 | 28 mars 1997 | Dissoute | Company Director | Administrateur | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0