ANDERSON STRATHERN WS
Dirigeant de société
Nom | ANDERSON STRATHERN WS |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 19 |
Total | 19 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
NUNIV DEVELOPMENTS LIMITED | 07 juin 1999 | 17 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
RENNIE MEIKLE LIMITED | 25 avr. 2000 | 26 mai 2004 | Active | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (DUNDEE) | 20 mai 1999 | 18 mars 2003 | Active | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
AUTOSCOT DOT COM LIMITED | 06 oct. 1999 | 03 oct. 2000 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
THE SUSTAINABLE FOOD COMPANY LIMITED | 13 déc. 1999 | 05 avr. 2000 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
CARSCAN LIMITED | 25 août 1999 | 15 sept. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
DRUMFIN LIMITED | 04 mai 1999 | 23 juin 1999 | Active | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
LOCH DUART PLC | 04 mai 1999 | 20 mai 1999 | Active | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
THOMSON RODDICK & MEDCALF LIMITED | 16 mars 1999 | 10 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
VERIMAC (NO. 94) LIMITED | 08 juil. 1998 | 25 mars 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
ARTHUR MCKAY (SUPPORT SERVICES) LIMITED | 16 mars 1999 | 17 mars 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
THE SUSTAINABLE SALMON COMPANY LIMITED | 29 oct. 1997 | 24 févr. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
LIVING WATER ECOSYSTEMS LTD. | 31 déc. 1997 | 21 févr. 1999 | Active | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
GLENMORE LOMOND PAPER GROUP LIMITED | 02 déc. 1998 | 02 déc. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
SUMDIALS LIMITED | 31 déc. 1997 | 21 avr. 1998 | Active | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
SILVERBANK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 31 déc. 1997 | 26 mars 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
AMOVA LIMITED | 11 nov. 1997 | 15 févr. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
A AND J BOWEN & COMPANY LIMITED | 11 nov. 1997 | 01 févr. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
JOHN MARTIN ACCIDENT REPAIRS LIMITED | 11 nov. 1997 | 13 nov. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | 48 Castle Street EH2 3LX Edinburgh |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0