Ann Heron GLOAG
Personne physique
| Titre | Mrs |
|---|---|
| Prénom | Ann |
| Deuxième prénom | Heron |
| Nom de famille | GLOAG |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 5 |
| Inactif | 8 |
| Démissionné | 13 |
| Total | 26 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOAG INVESTMENTS GROUP LIMITED | 06 oct. 2016 | Active | Administrateur | George Street EH2 2LR Edinburgh 56 Scotland | Scotland | British | ||
| HIGHLAND & UNIVERSAL LAND LIMITED | 28 avr. 2016 | Active | Administrateur | George Street EH2 2LR Edinburgh 56 Scotland | Scotland | British | ||
| ARCHANGELS INVESTMENTS LLP | 04 déc. 2014 | Dissoute | Membre de la LLP | Rutland Square EH1 2BB Edinburgh 20 | Scotland | |||
| MANSTON SKYPORT LIMITED | 19 sept. 2013 | Active | Administrateur | George Street EH2 2LR Edinburgh 56 Scotland | Scotland | British | ||
| CROFTMUIR LIMITED | 08 mars 2012 | Active | Administrateur | George Street Floor 2 EH2 2LR Edinburgh 56 Scotland | Scotland | British | ||
| QUARRYMILL LLP | 01 déc. 2011 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | George Street EH2 2LR Edinburgh 56 Scotland | Scotland | |||
| THINK HAPPY LIMITED | 07 nov. 2008 | Dissoute | Administrateur | B1, Highland House St Catherines Road PH1 5RY Perth Gloag Investments Perthshire United Kingdom | Scotland | British | ||
| HERONTRUSTEES LIMITED | 28 mars 2008 | Dissoute | Administrateur | Beaufort Castle IV4 7BB Beauly Inverness-Shire | Scotland | British | ||
| GLENDEVON LEISURE LLP | 18 mai 2007 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Beaufort Castle IV4 7BB Beauly | Scotland | |||
| GLENDEVON LANDS LLP | 18 mai 2007 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Beaufort Castle IV4 7BB Beauly | Scotland | |||
| SERAPHIM CAPITAL (GENERAL PARTNER) LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | 07 sept. 2006 | Dissoute | Membre de la LLP | Beaufort Castle IV4 7BB Beauly | Scotland | |||
| DEUCHNY PROPERTIES LLP | 29 août 2006 | Active | Membre désigné de la LLP | Beaufort Castle IV4 7BB Beauly | Scotland | |||
| KIARIE LTD. | 14 avr. 2004 | Dissoute | Administrateur | B1, Highland House St Catherines Road PH1 5RY Perth Gloag Investments Perthshire United Kingdom | Scotland | British | ||
| CRAIGROSSIE PROPERTIES (NO.1) LIMITED | 17 août 2010 | 16 juil. 2021 | Active | Administrateur | George Street Floor 2 EH2 2LR Edinburgh 56 Scotland | Scotland | British | |
| CRAIGROSSIE PROPERTIES LIMITED | 29 juil. 2010 | 16 juil. 2021 | Active | Administrateur | George Street Floor 2 EH2 2LR Edinburgh 56 Scotland | Scotland | British | |
| MERCY SHIPS - U.K. LIMITED | 01 juil. 2008 | 25 mars 2019 | Active | Administrateur | Beaufort Castle IV4 7BB Beauly Inverness-Shire | Scotland | British | |
| GLOAG INVESTMENT PROPERTIES PORTFOLIO 2 LIMITED | 05 juil. 2016 | 06 sept. 2018 | Active | Administrateur | George Street EH2 2LR Edinburgh 56 Scotland | Scotland | British | |
| GLOAG INVESTMENT PROPERTIES LIMITED | 27 janv. 2016 | 06 sept. 2018 | Active | Administrateur | George Street EH2 2LR Edinburgh 56 Scotland | Scotland | British | |
| AFRICAN LAKES PHILANTHROPY LTD | 23 sept. 2005 | 15 sept. 2017 | Active | Administrateur | Beaufort Castle IV4 7BB Beauly Inverness-Shire | Scotland | British | |
| INVERDUNNING (SOUTH) LIMITED | 15 janv. 2016 | 28 janv. 2017 | Active | Administrateur | c/o C/O Greyfriars Investments Limited George Street EH2 2LR Edinburgh 56 Scotland | Scotland | British | |
| COMCARDE LIMITED | 19 mai 2015 | 06 oct. 2016 | Active | Administrateur | Drummond Street IV1 1QF Inverness 5 | Scotland | British | |
| EDINBURGH Q STREET PROPCO LTD | 15 sept. 2016 | 21 sept. 2016 | Active | Administrateur | George Street EH2 2LR Edinburgh 56 United Kingdom | Scotland | British | |
| BONHARD LEASING LLP | 15 févr. 2005 | 31 mars 2015 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Beaufort Castle IV4 7BB Beauly | Scotland | ||
| WILD ORGANICS LIMITED | 07 nov. 2008 | 31 mars 2012 | Dissoute | Administrateur | B1, Highland House St Catherines Road PH1 5RY Perth Gloag Investments Perthshire United Kingdom | Scotland | British | |
| OS MARCH 2012 LIMITED | 11 sept. 2007 | 31 mars 2012 | Dissoute | Administrateur | B1, Highland House St Catherines Road PH1 5RY Perth Gloag Investments Perthshire United Kingdom | Scotland | British | |
| MPATHY MEDICAL DEVICES LIMITED | 01 oct. 2009 | 29 oct. 2010 | Dissoute | Administrateur | c/o Ramsay Gillies, Gloag Investments St. Catherines Road PH1 5RY Perth Suite B1 Highland House Scotland | Scotland | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0