@UKPLC CLIENT SECRETARY LTD
Dirigeant de société
Nom | @UKPLC CLIENT SECRETARY LTD |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 4 |
Inactif | 124 |
Démissionné | 1191 |
Total | 1319 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
4TH EARTH LIMITED | 12 avr. 2015 | 05 févr. 2025 | Active | Secrétaire | 2 Woodberry Grove Finchley N12 0DR London Winnington House United Kingdom |
ERIGINAL LTD | 20 août 2008 | 07 oct. 2024 | Active | Secrétaire | Jupiter House Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Berkshire United Kingdom |
OMNI CHANNEL FULFILMENT LIMITED | 09 avr. 2018 | 09 août 2024 | Active | Secrétaire | 2 Woodberry Grove Finchley N12 0DR London Winnington House United Kingdom |
TOP MARKETING UK LTD | 26 janv. 2011 | 19 déc. 2023 | Active | Secrétaire | 2 Woodberry Grove Finchley N12 0DR London Winnington House England |
BRECON OPERATIONS LIMITED | 10 déc. 2016 | 27 nov. 2023 | Active | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
EMMERTON LAND LIMITED | 12 sept. 2016 | 19 sept. 2023 | Active | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
GIFFORD STREET LIMITED | 24 juil. 2017 | 14 juil. 2023 | Active | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
CYBERNETOLOGY LIMITED | 20 juin 2017 | 11 juil. 2023 | Active | Secrétaire | 2 Woodberry Grove Finchley N12 0DR London Winnington House England |
THE LONDON COLLEGE (KENSINGTON) LIMITED | 30 déc. 2015 | 19 mai 2023 | Active | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
MARNEY CAPITAL LTD | 06 juin 2015 | 19 mai 2023 | Active | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
UNI COLLEGE KENSINGTON LIMITED | 06 mars 2006 | 19 mai 2023 | Active | Secrétaire | 5 Jupiter House Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading Berkshire |
K3N LIMITED | 13 sept. 2015 | 17 mai 2023 | Active | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
CONTEMPORARY SOUNDWORKS LIMITED | 05 mars 2013 | 12 mai 2023 | Active | Secrétaire | Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Berkshire United Kingdom |
AEQOS CONSULTING LTD | 22 août 2006 | 12 mai 2023 | Active | Secrétaire | 5 Jupiter House Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading Berkshire |
AEQOS QUALITY MANAGEMENT LTD | 29 nov. 2006 | 17 avr. 2023 | Active | Secrétaire | 5 Jupiter House Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading Berkshire |
STEBEL ITALIA PLC | 15 mars 2012 | 06 avr. 2023 | Active | Secrétaire | 2 Woodberry Grove Finchley N12 0DR London Winnington House United Kingdom |
BILBIZ GLOBAL PLC | 12 mars 2012 | 06 avr. 2023 | Active | Secrétaire | 2 Woodberry Grove Finchley N12 0DR London Winnington House United Kingdom |
AGORA CONFERENCES INTERNATIONAL LTD | 18 août 2004 | 29 mars 2023 | Active | Secrétaire | 2 Woodberry Grove Finchley N12 0DR London Winnington House England |
THE TREE AGENCY LIMITED | 06 août 2016 | 28 mars 2023 | Active | Secrétaire | 2 Woodberry Grove Finchley N12 0DR London Winnington House England |
FENCEFIX LIMITED | 08 nov. 2013 | 17 mars 2023 | Active | Secrétaire | Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Berkshire United Kingdom |
AFROHAWK ENERGY LIMITED | 05 févr. 2013 | 14 mars 2023 | Dissoute | Secrétaire | Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Berkshire United Kingdom |
FREIGHT MOVERS LIMITED | 24 sept. 2016 | 08 mars 2023 | Dissoute | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
VELADOR ASSOCIATES LTD | 28 janv. 2015 | 31 janv. 2023 | Active | Secrétaire | Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Berkshire United Kingdom |
MCSE-2000.NET LTD | 30 janv. 2004 | 31 janv. 2023 | Dissoute | Secrétaire | 5 Jupiter House Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading Berkshire |
BLUE CHIP CAPITAL INVESTMENTS PLC | 07 déc. 2016 | 12 oct. 2022 | Active | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
THE MATTHEW TREE PROJECT | 24 août 2017 | 04 févr. 2022 | Active | Secrétaire | 2 Woodberry Grove Finchley N12 0DR London Winnington House England |
UNITED PROPERTY PROJECTS LIMITED | 19 sept. 2018 | 29 oct. 2021 | Active | Secrétaire | Woodberry Grove N12 0DR North Finchley 2 London England |
RAM SPREADERS UK LTD | 18 déc. 2008 | 14 juil. 2021 | Dissoute | Secrétaire | Jupiter House Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Berkshire United Kingdom |
RAM SPREADERS LTD | 18 déc. 2008 | 14 juil. 2021 | Dissoute | Secrétaire | Jupiter House Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Berkshire United Kingdom |
WEBCENTER LIMITED | 20 juil. 2018 | 04 juin 2021 | Dissoute | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
BRAXTON PUBLISHING LTD | 22 oct. 2003 | 26 mai 2021 | Dissoute | Secrétaire | 5 Jupiter House Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading Berkshire |
CALL BRIAN.COM LIMITED | 20 mars 2019 | 25 mai 2021 | Active | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
PUNTI LIMITED | 18 juin 2017 | 24 mai 2021 | Dissoute | Secrétaire | 2 Woodberry Grove Finchley N12 0DR London Winnington House England |
GTT GROUP PLC | 28 août 2018 | 14 mai 2021 | Dissoute | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
TECHINLINE LIMITED | 01 août 2017 | 23 avr. 2021 | Dissoute | Secrétaire | Calleva Park Aldermaston RG7 8NN Reading 5 Jupiter House Berkshire United Kingdom |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0