Christopher George ANDERSON
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Christopher |
Deuxième prénom | George |
Nom de famille | ANDERSON |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 2 |
Inactif | 10 |
Démissionné | 10 |
Total | 22 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROWN RIVIERA (PALM) LIMITED | 11 nov. 2015 | Dissoute | Real Estate Advisory | Administrateur | Chenies Village Chenies WD3 6EQ Rickmansworth Home Close Cottage Hertfordshire England | England | British | |
CROWN CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL LTD | 27 févr. 2015 | Dissoute | Real Estate Advisory | Administrateur | Chenies Village Chenies WD3 6EQ Rickmansworth Home Close Cottage Hertfordshire United Kingdom | England | British | |
RICHES ANDERSON LLP | 17 juin 2013 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Chenies Village Chenies WD3 6EQ Rickmansworth Home Close United Kingdom | England | |||
ANDERSON RICHES (FRANCE) LIMITED | 13 avr. 2010 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 England | England | British | |
ANDERSON RICHES GROUP LIMITED | 11 mars 2010 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 England | England | British | |
SNAILWELL BARNS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 08 sept. 2008 | Dissoute | Surveyor | Administrateur | Home Close Cottage Chenies Village WD3 6EQ Rickmansworth Herts | England | British | |
STOUR BROOK LIMITED | 16 juil. 2008 | Dissoute | Surveyor | Administrateur | Home Close Cottage Chenies Village WD3 6EQ Rickmansworth Herts | England | British | |
105 NORTH STREET LIMITED | 23 févr. 2007 | Receveur désigné | Company Director | Administrateur | Home Close Cottage Chenies Village WD3 6EQ Rickmansworth Herts | England | British | |
EUROBOURNE PROPERTIES LIMITED | 24 juil. 2003 | Active | Surveyor | Administrateur | Home Close Cottage Chenies Village WD3 6EQ Rickmansworth Herts | England | British | |
ANDERSON FEAST PROFESSIONAL LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | 27 sept. 2001 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Home Close Cottage Chenies Village WD3 6EQ Rickmansworth | England | |||
EELBROOK PROPERTIES LIMITED | 30 janv. 1995 | Dissoute | Managing Director | Administrateur | Home Close Cottage Chenies Village WD3 6EQ Rickmansworth Herts | England | British | |
FEDERAL EUROPEAN PROPERTIES LIMITED | Dissoute | Managing Director | Administrateur | Home Close Cottage Chenies Village WD3 6EQ Rickmansworth Herts | England | British | ||
BARBER HONEY RIVIERA (PALM) LIMITED | 26 janv. 2017 | 13 oct. 2020 | Dissoute | Director | Administrateur | Conduit Lane EN11 8EP Hoddesdon Unit 4 Limes Court Hertfordshire England | England | British |
LE PALM CANNES LIMITED | 24 oct. 2016 | 07 sept. 2020 | Dissoute | Real Estate Adviser | Administrateur | Corinthia Hotel SW1A 2BD Whitehall Place International Hotel Investments Plc (Ihi London England | England | British |
MILL HILL (NEWMARKET) LIMITED | 28 juil. 2006 | 20 juin 2008 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Home Close Cottage Chenies Village WD3 6EQ Rickmansworth Herts | England | British |
AUGURSHIP 104 LIMITED | 28 août 1998 | 26 sept. 2002 | Active | Secrétaire | The Cottage 12 Jackets Lane HA6 2SH Northwood Middlesex | British | ||
CDL ITALY LIMITED | 27 nov. 1996 | 26 sept. 2002 | Active | Secrétaire | The Cottage 12 Jackets Lane HA6 2SH Northwood Middlesex | British | ||
5 EARL'S COURT SQUARE LIMITED | 09 avr. 2001 | 09 sept. 2002 | Active | Company Director | Administrateur | The Cottage 12 Jackets Lane HA6 2SH Northwood Middlesex | British | |
ANDERSON HARVY LIMITED | 08 févr. 1995 | 03 juin 1998 | Dissoute | Director | Administrateur | The Cottage 12 Jackets Lane HA6 2SH Northwood Middlesex | British | |
ANDERSON HARVY LIMITED | 08 févr. 1995 | 03 juin 1998 | Dissoute | Director | Secrétaire | The Cottage 12 Jackets Lane HA6 2SH Northwood Middlesex | British | |
SIGNUM LIMITED | 08 déc. 1995 | Active | Secrétaire | The Cottage 12 Jackets Lane HA6 2SH Northwood Middlesex | British | |||
FEDERAL EUROPEAN PROPERTIES LIMITED | 08 déc. 1995 | Dissoute | Secrétaire | The Cottage 12 Jackets Lane HA6 2SH Northwood Middlesex | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0