Anthony Jonathan SHAKESBY
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Anthony |
Deuxième prénom | Jonathan |
Nom de famille | SHAKESBY |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 2 |
Inactif | 6 |
Démissionné | 18 |
Total | 26 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDM AERO LIMITED | 05 juil. 2017 | Active | Director | Administrateur | Badgers Walk BH22 9QF Ferndown 14 Dorset England | England | British | |
GROUPJET LIMITED | 02 oct. 2013 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Quayside Chatham Maritime ME4 4QU Chatham Montague Place Kent | England | British | |
OP ADVISORY LIMITED | 24 sept. 2013 | Active | Director | Administrateur | Badgers Walk BH22 9QF Ferndown 14 Dorset England | England | British | |
AVIONICS MOBILE DESIGN SERVICES LIMITED | 03 janv. 2012 | Dissoute | Accountant | Administrateur | South East Sector Bournemouth International Airport, Hurn BH23 6SE Christchurch Building 332 Dorset England | England | British | |
ML2 AVIONICS LIMITED | 21 janv. 2011 | Dissoute | Director | Administrateur | South East Sector Bournemouth International Airport, Hurn BH23 6SE Christchurch Building 332 Dorset United Kingdom | England | British | |
OP & JT SERVICES LIMITED | 08 janv. 2010 | Dissoute | Director | Administrateur | 41-43 Boltro Road RH16 1BJ Haywards Heath Maxwelton House West Sussex | England | British | |
AVIONICS MOBILE DESIGN SERVICES LIMITED | 20 juil. 2004 | Dissoute | Secrétaire | South East Sector Bournemouth International Airport, Hurn BH23 6SE Christchurch Building 332 Dorset England | British | |||
THE GAINSBOROUGH TRADING POST LIMITED | 25 oct. 2000 | Dissoute | Chartered Accountant | Administrateur | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | England | British | |
JETS (BIGGIN HILL) LIMITED | 03 janv. 2012 | 20 déc. 2020 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Quayside Chatham Maritime ME4 4QU Chatham Montague Place | England | British |
JETS (BOURNEMOUTH) LIMITED | 24 mars 2005 | 28 déc. 2018 | Liquidation | Accountant | Administrateur | South East Sector Bournemouth International Airport, Hurn BH23 6SE Christchurch Building 332 Dorset United Kingdom | England | British |
SIERRA NEVADA UK LIMITED | 21 août 2007 | 30 janv. 2015 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Houndsditch EC3A 7AR London The St Botolph Building 138 United Kingdom | England | British |
GALILEO RESOURCES PLC | 03 févr. 2006 | 26 juin 2012 | Active | Accountant | Secrétaire | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | British | |
GALILEO RESOURCES PLC | 03 févr. 2006 | 12 mars 2012 | Active | Accountant | Administrateur | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | England | British |
CLUB 328 LIMITED | 01 févr. 2005 | 10 oct. 2007 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | England | British |
CLUB 328 LIMITED | 21 août 2003 | 10 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | British | ||
CORPORATE JET REALISATIONS LIMITED | 13 nov. 2002 | 26 sept. 2007 | Dissoute | Finance Director | Secrétaire | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | British | |
CORPORATE JET REALISATIONS LIMITED | 13 nov. 2002 | 26 sept. 2007 | Dissoute | Finance Director | Administrateur | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | England | British |
ASSET FUND MANAGERS LIMITED | 22 mai 1997 | 31 mars 2006 | Dissoute | Secrétaire | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | British | ||
IMMUPHARMA PLC | 21 févr. 2000 | 15 févr. 2006 | Active | Director | Secrétaire | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | British | |
IMMUPHARMA PLC | 21 févr. 2000 | 15 févr. 2006 | Active | Director | Administrateur | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | England | British |
KIWARA LIMITED | 02 juil. 1999 | 20 juin 2000 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | England | British |
KIWARA LIMITED | 02 juil. 1999 | 20 juin 2000 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | British | |
REGINA HEALTH LIMITED | 23 juin 1994 | Active | Secrétaire | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | British | |||
REGINA HEALTH LIMITED | 23 juin 1994 | Active | Director | Administrateur | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | England | British | |
NORDIC PANORAMA PLC | 27 févr. 1991 | 23 juin 1994 | Dissoute | Finance Director | Administrateur | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | England | British |
NORDIC PANORAMA PLC | 27 févr. 1991 | 23 juin 1994 | Dissoute | Finance Director | Secrétaire | 90 Atlantic Close SO14 3TB Southampton Hampshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0