Colin George BARRAL (DECEASED)
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Colin |
Deuxième prénom | George |
Nom de famille | BARRAL |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 10 |
Démissionné | 32 |
Total | 43 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LIMITED | 27 juin 2017 | Dissoute | Management Consultant | Administrateur | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British | |
PROFIT MATTERS CONSULTING LTD | 27 avr. 2017 | Active | Consultant | Administrateur | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 | Scotland | British | |
@SSAS (UK) LIMITED | 08 oct. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | 53 Bothwell Street G2 6TS Glasgow 6th Floor Mercantile Building | Scotland | British | |
LEGGAT AVIATION LIMITED | 07 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | |||
DAVID GARRETT DENTAL SURGERY LTD. | 09 nov. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Gordon Chambers 90 Mitchell Street G1 3NQ Glasgow 6th Floor Scotland | British | |||
K.E. BELL LTD. | 10 juil. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | |||
ZEN PRODUCTIONS LIMITED | 12 sept. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | |||
REAL RENTING LTD. | 09 juin 2005 | Dissoute | Secrétaire | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | British | |||
SECRETARIAL-DATA PEOPLE LTD. | 18 févr. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | |||
BARRAL FINANCIAL SERVICES LTD | 28 oct. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 13 Glasgow Road Paisley PA1 3QS | British | |||
MACKIE REAL ESTATE LIMITED | 14 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | |||
@SSAS (PENSION TRUSTEES) LTD | 01 avr. 2012 | 03 janv. 2024 | Active | Director | Administrateur | 53 Bothwell Street G2 6TS Glasgow 6th Floor Mercantile Building Scotland | Scotland | British |
@SIPP LIMITED | 26 sept. 2001 | 02 mars 2023 | Active | Pensions Consultant | Administrateur | Eaglesham G76 0PL Glasgow Ardoch Lodge Scotland | Scotland | British |
@SIPP (PENSION TRUSTEES) LIMITED | 23 mars 2001 | 02 mars 2023 | Active | Pensions Consultant | Administrateur | Eaglesham G76 0PL Glasgow Ardoch Lodge Scotland | Scotland | British |
SPIRIT OF CAIRNGORM LTD | 03 févr. 2021 | 01 mars 2023 | Active | Managing Director | Administrateur | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | Scotland | British |
BRITE HOLDINGS AND INVESTMENTS LTD. | 07 mars 2018 | 01 mars 2023 | Active | Director | Administrateur | 5 Newton Terrace G3 7PJ Glasgow Berkeley House Scotland | Scotland | British |
BERKELEY CLINIC UK LTD | 07 nov. 2017 | 01 mars 2023 | Active | Accountant | Administrateur | Newton Terrace G3 7PJ Glasgow 5 United Kingdom | Scotland | British |
BRITE HOLDINGS (SCOTLAND) LIMITED | 21 juil. 2017 | 01 mars 2023 | Active | Director | Administrateur | 5 Newton Terrace G3 7PJ Glasgow Berkeley House | Scotland | British |
FOURPLY LTD. | 21 nov. 2015 | 01 mars 2023 | Active | Director | Administrateur | 13 Glasgow Road Paisley PA1 3QS Renfrewshire | Scotland | British |
FOURPLY SPECIALIST COATINGS LTD. | 17 nov. 2008 | 01 mars 2023 | Active | Secrétaire | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 | British | ||
THE MARTIN PROPERTY COMPANY LIMITED | 01 déc. 2007 | 01 mars 2023 | Active | Secrétaire | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire United Kingdom | British | ||
I-DENTIFY SCOTLAND LTD. | 20 juin 2005 | 01 mars 2023 | Active | Secrétaire | 13 Glasgow Road Paisley PA1 3QS | British | ||
REAL RENTS LTD. | 15 mars 2005 | 01 mars 2023 | Active | Secrétaire | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire | British | ||
REAL LETTING LTD. | 25 févr. 2003 | 01 mars 2023 | Active | Accountant | Secrétaire | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | British | |
FOURPLY LTD. | 05 févr. 2001 | 01 mars 2023 | Active | Secrétaire | 13 Glasgow Road Paisley PA1 3QS Renfrewshire | British | ||
PANESAR PROPERTIES LTD. | 16 juin 2006 | 28 févr. 2021 | Active | Secrétaire | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | ||
THE GARTH HOTEL AND LUXURY LODGES LIMITED | 20 mars 2001 | 03 mai 2019 | Dissoute | Secrétaire | 13 Glasgow Road Paisley PA1 3QS Renfrewshire | British | ||
HOTEL CONNEXIONS LIMITED | 21 nov. 2015 | 05 août 2016 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | Scotland | British |
STRATHCLYDE VULCANISING SERVICES LIMITED | 21 nov. 2015 | 20 juin 2016 | Active | Director | Administrateur | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | Scotland | British |
BARRAL SHEPPARD FINANCIAL SERVICES LLP | 24 avr. 2015 | 15 mai 2015 | Dissoute | Membre de la LLP | Glasgow Road PA1 3QS Paisley 13 Renfrewshire Scotland | Scotland | ||
@SSAS (PENSION TRUSTEES) LTD | 12 juil. 2001 | 01 avr. 2012 | Active | Secrétaire | Eaglesham G79 0PL Glasgow Ardoch Lodge Scotland | British | ||
BRAEDALE AERIALS LTD | 14 sept. 2001 | 18 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | ||
PROFIT COUNTS LIMITED | 14 juin 2004 | 30 sept. 2008 | Active | Secrétaire | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | ||
JCT CONTRACTS LTD. | 21 juin 2006 | 05 sept. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British | ||
PREMIER CONSTRUCTION (SCOTLAND) LTD. | 25 avr. 2000 | 30 juin 2008 | Dissoute | Secrétaire | Ardoch Lodge Eaglesham G76 0PL Glasgow Lanarkshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0