Graeme James COOK
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Graeme |
| Deuxième prénom | James |
| Nom de famille | COOK |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 0 |
| Démissionné | 17 |
| Total | 17 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXPORT UK LIMITED | 01 oct. 2014 | 08 juin 2017 | Active | Administrateur | The Warren KT21 2SA Ashtead The Downs Surrey | United Kingdom | British | |
| DAXPORT SCOTLAND LTD | 29 janv. 2015 | 01 juin 2017 | Active | Administrateur | 38 Beansburn KA3 1RL Kilmarnock C/O Ids And Co Ayrshire Scotland | United Kingdom | British | |
| THE BOUTIQUE HOME COMPANY (SCOTLAND) LTD | 01 juin 2015 | 01 mars 2016 | Dissoute | Administrateur | Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow 4 Scotland | United Kingdom | British | |
| PANOPTIC INVESTMENTS PTE LIMITED | 08 nov. 2011 | 30 juin 2015 | Converti / Fermé | Administrateur | 2 Seaward Place Centurion Business Park G41 1HH Glasgow 1 Uk | United Kingdom | British | |
| XINTRONIX LIMITED | 26 avr. 2013 | 14 sept. 2014 | Dissoute | Administrateur | Station Approach Temple Meads BS1 6QH Bristol The Engine Shed England | United Kingdom | British | |
| FUTURE TECHNOLOGY DEVICES INTERNATIONAL LIMITED | 01 mars 2011 | 12 sept. 2014 | Active | Administrateur | Seaward Place Centurion Business Park G41 1HH Glasgow 2 | United Kingdom | British | |
| JTI REALISATIONS LIMITED | 17 févr. 2006 | 01 oct. 2006 | Dissoute | Administrateur | 4 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow | United Kingdom | British | |
| JTI REALISATIONS LIMITED | 22 déc. 2004 | 30 sept. 2005 | Dissoute | Administrateur | 4 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow | United Kingdom | British | |
| RENEWAL ENTERPRISES LIMITED | 22 déc. 2004 | 30 sept. 2005 | Dissoute | Administrateur | 4 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow | United Kingdom | British | |
| STRONGHOLD INTERNATIONAL LIMITED | 20 juil. 2004 | 30 sept. 2005 | Active | Secrétaire | 4 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow | British | ||
| TONY BEAL LIMITED | 20 juil. 2004 | 30 sept. 2005 | Active | Secrétaire | 4 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow | British | ||
| BEAL MANUFACTURING HOLDINGS LTD | 20 juil. 2004 | 30 sept. 2005 | Active | Secrétaire | 4 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow | British | ||
| GARDEN MARQUEES LIMITED | 30 avr. 2004 | 30 sept. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 4 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow | British | ||
| BCT REALISATIONS LIMITED | 16 avr. 2004 | 30 sept. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 4 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow | British | ||
| BCT REALISATIONS LIMITED | 03 mars 2004 | 30 sept. 2005 | Dissoute | Administrateur | 4 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow | United Kingdom | British | |
| JTI REALISATIONS LIMITED | 16 févr. 2004 | 30 sept. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 4 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow | British | ||
| RENEWAL ENTERPRISES LIMITED | 16 févr. 2004 | 30 sept. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 4 Broomvale Drive Newton Mearns G77 5NN Glasgow | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0