Michael Graham IRWIN
Personne physique
| Titre | |
|---|---|
| Prénom | Michael |
| Deuxième prénom | Graham |
| Nom de famille | IRWIN |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 8 |
| Démissionné | 20 |
| Total | 28 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUIM FADA WIND ENERGY LIMITED | 03 mai 2011 | Dissoute | Administrateur | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | Scotland | British | ||
| MARGREE WIND ENERGY LIMITED | 12 oct. 2010 | Dissoute | Administrateur | 319 St Vincent Street G2 5AS Glasgow C/O Kpmg Llp | Scotland | British | ||
| WILKINS (LUV) ENGINEERING LIMITED | 14 sept. 2004 | Dissoute | Secrétaire | Garden Cottage Warroch House KY13 0RS Kinross Fife | British | |||
| NBW REALISATIONS LIMITED | 06 août 2003 | Dissoute | Administrateur | 95 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Apex 3, | Scotland | British | ||
| NBW REALISATIONS LIMITED | 06 août 2003 | Dissoute | Secrétaire | 95 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Apex 3, | British | |||
| BH 2003 LIMITED | 06 août 2003 | Dissoute | Administrateur | 50 Lothian Road Edinburgh EH3 9WJ Midlothian | Scotland | British | ||
| BH 2003 LIMITED | 06 août 2003 | Dissoute | Secrétaire | 50 Lothian Road Edinburgh EH3 9WJ Midlothian | British | |||
| WILKINS (LUV) ENGINEERING LIMITED | 18 juin 2001 | Dissoute | Administrateur | Garden Cottage Warroch House KY13 0RS Kinross Fife | Scotland | British | ||
| NORTH BRITISH WINDPOWER LIMITED | 20 févr. 2015 | 20 avr. 2026 | Active | Administrateur | Redheugh TD9 0SB Newcastleton Redheugh Roxburghshire Scotland | Scotland | British | |
| NBW (NOMINEES) LIMITED | 29 sept. 2005 | 20 avr. 2026 | Active | Secrétaire | TD9 0SB Newcastleton Redheugh Roxburghshire Scotland | British | ||
| NBW (NOMINEES) LIMITED | 29 sept. 2005 | 20 avr. 2026 | Active | Administrateur | TD9 0SB Newcastleton Redheugh Roxburghshire Scotland | Scotland | British | |
| NORTH BRITISH WINDPOWER LIMITED | 30 avr. 2004 | 20 avr. 2026 | Active | Secrétaire | Garden Cottage Warroch House KY13 0RS Kinross Fife | British | ||
| BALUNTON WIND ENERGY LIMITED | 09 avr. 2013 | 16 janv. 2025 | Dissoute | Administrateur | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | Scotland | British | |
| PENCLOE WIND ENERGY LIMITED | 03 mai 2011 | 16 janv. 2025 | Active | Administrateur | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | Scotland | British | |
| BH WIND ENERGY LIMITED | 23 août 2010 | 16 janv. 2025 | Dissoute | Administrateur | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | Scotland | British | |
| ULZIESIDE WIND ENERGY LIMITED | 12 oct. 2010 | 29 janv. 2016 | Active | Administrateur | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 | Scotland | British | |
| CORRIEGARTH WIND ENERGY HOLDINGS LIMITED | 17 nov. 2005 | 02 oct. 2015 | Dissoute | Administrateur | 50 Lothian Road Edinburgh EH3 9WJ Midlothian | Scotland | British | |
| CORRIEGARTH WIND ENERGY HOLDINGS LIMITED | 06 août 2003 | 02 oct. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 50 Lothian Road Edinburgh EH3 9WJ Midlothian | British | ||
| BETTYHILL WIND ENERGY LIMITED | 23 août 2010 | 19 déc. 2013 | Active | Administrateur | Lochside House 3 Lochside Way, Edinburgh Park EH12 9DT Edinburgh Nbw Wind Energy Limited Scotland | Scotland | British | |
| FALLAGO RIG WINDFARM LIMITED | 26 sept. 2003 | 23 déc. 2011 | Active | Secrétaire | Garden Cottage Warroch House KY13 0RS Kinross Fife | British | ||
| FALLAGO RIG WINDFARM LIMITED | 14 août 2002 | 23 déc. 2011 | Active | Administrateur | Garden Cottage Warroch House KY13 0RS Kinross Fife | Scotland | British | |
| CORRIEGARTH WIND ENERGY HOLDINGS LIMITED | 06 août 2003 | 17 nov. 2005 | Dissoute | Administrateur | Garden Cottage Warroch House KY13 0RS Kinross Fife | Scotland | British | |
| THERMOREPORT LIMITED | 31 oct. 1996 | 26 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Fowberry Mains NE71 6EN Wooler Northumberland | British | ||
| THERMOREPORT LIMITED | 31 oct. 1996 | 26 août 1998 | Dissoute | Administrateur | Fowberry Mains NE71 6EN Wooler Northumberland | British | ||
| ELECTRIC VEHICLE SYSTEMS LIMITED | 02 avr. 1996 | 31 oct. 1996 | Active | Secrétaire | Fowberry Mains NE71 6EN Wooler Northumberland | British | ||
| ELECTRIC VEHICLE SYSTEMS LIMITED | 21 mars 1995 | 31 oct. 1996 | Active | Administrateur | Fowberry Mains NE71 6EN Wooler Northumberland | British | ||
| ELITE OPTICS LIMITED | 18 nov. 1991 | 13 sept. 1993 | Dissoute | Administrateur | Dial Cottage Coddenham Green IP6 9UN Ipswich Suffolk | British | ||
| ELITE OPTICS LIMITED | 18 nov. 1991 | 29 nov. 1991 | Dissoute | Secrétaire | Dial Cottage Coddenham Green IP6 9UN Ipswich Suffolk | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0