Gregory KARATHANOS
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Gregory |
Nom de famille | KARATHANOS |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 10 |
Inactif | 14 |
Démissionné | 3 |
Total | 27 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCJ FOOD COMPANY LIMITED | 29 oct. 2021 | Active | Company Director | Administrateur | Manchester Square W1U 3PP London Milner House 14 England | England | British | |
GLOBAL TRADING HOUSE LONDON LTD | 19 janv. 2021 | Active | Director | Administrateur | Cowbridge Road East CF5 1BJ Cardiff 474 | England | British | |
10 DEGREES BRANDS LTD | 05 févr. 2016 | Dissoute | Director | Administrateur | 14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House London England | England | British | |
ESPRESSO ROOMS UK LTD | 27 mai 2015 | Active | Director | Administrateur | 14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House London England | England | British | |
INTERNATIONAL BUILDING SUPPLIES LIMITED | 27 mai 2015 | Active | Director | Administrateur | 14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House London England | England | British | |
MAVI ART LTD | 12 mai 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | 14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House London England | England | British | |
CIRRUS HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED | 01 sept. 2011 | Active | Director | Administrateur | 14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House London England | England | British | |
SMART AD MEDIA LIMITED | 01 sept. 2011 | Dissoute | Director | Administrateur | 14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House London England | England | British | |
SULTANA LIMITED | 01 sept. 2011 | Dissoute | Director | Administrateur | 14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House London England | England | British | |
GLOBAL BUSINESS SERVICES LIMITED | 25 août 2011 | Active | Accountant | Administrateur | Forth Street EH1 3LH Edinburgh 16 Scotland | England | British | |
COOLBILLBOARDS (EUROPE) LIMITED | 25 août 2011 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Milner House 14 Manchester Square W1U 3PP London | England | British | |
EGO FASHION BOX LIMITED | 25 août 2011 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 60 Constitution Street Leith EH6 6RR Edinburgh Cowan & Partners Midlothian Scotland | England | British | |
ESPRESSO ROOMS UK LTD | 01 mai 2011 | Active | Secrétaire | 12-14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House United Kingdom | British | |||
EGO FASHION BOX LONDON LIMITED | 01 mars 2011 | Dissoute | Secrétaire | 14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House London United Kingdom | British | |||
EGO FASHION BOX LONDON LIMITED | 01 mars 2011 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House London United Kingdom | England | British | |
TREPEZ (UK) LIMITED | 28 févr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 16 Comely Park Dunfermline KY12 7HU Fife | British | |||
SMART AD MEDIA LIMITED | 01 janv. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 60 Constitution Street Leith EH6 6RR Edinburgh Cowan & Partners Midlothian Scotland | British | |||
COOL CAR MEDIA LIMITED | 01 janv. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 60 Constitution Street Leith EH6 6RR Edinburgh Cowan & Partners Midlothian Scotland | British | |||
GLOBAL BUSINESS SERVICES LIMITED | 31 déc. 2010 | Active | Secrétaire | Forth Street EH1 3LH Edinburgh 16 Scotland | British | |||
INTERNATIONAL BUILDING SUPPLIES LIMITED | 31 déc. 2010 | Active | Secrétaire | 14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House London England | British | |||
SULTANA LIMITED | 31 déc. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 16 Comely Park Dunfermline KY12 7HU Fife | British | |||
COOLBILLBOARDS (EUROPE) LIMITED | 31 déc. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Milner House 14 Manchester Square W1U 3PP London | British | |||
EGO FASHION BOX LIMITED | 31 déc. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 60 Constitution Street Leith EH6 6RR Edinburgh Cowan & Partners Midlothian Scotland | British | |||
FINEST ACCOUNTS LIMITED | 31 mars 2008 | Active | Secrétaire | 66 Belmont Avenue EN4 9LA Cockfosters Hertfordshire | British | |||
IVOLT LTD | 01 sept. 2011 | 02 mars 2023 | Active | Non-Executive Director | Administrateur | 14 Waterside Drive Langley SL3 6EZ Slough Sollatek House Berkshire United Kingdom | England | British |
KIMA ARCHITECTURE & INTERIORS LTD | 01 oct. 2014 | 05 avr. 2016 | Dissoute | Director | Administrateur | 14 Manchester Square W1U 3PP London Milner House | England | British |
FINEST ACCOUNTS LIMITED | 17 déc. 2004 | 01 nov. 2005 | Active | Director | Administrateur | 66 Belmont Avenue EN4 9LA Cockfosters Hertfordshire | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0