David Harold BAINES
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | David |
| Deuxième prénom | Harold |
| Nom de famille | BAINES |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 8 |
| Inactif | 1 |
| Démissionné | 13 |
| Total | 22 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORGE CARE HOMES LIMITED | 20 mars 2009 | Active | Administrateur | Parret Road Bettws NP20 7DQ Newport Millheath Nursing Home Gwent United Kingdom | Wales | British | ||
| FC MILL HEATH LTD | 28 févr. 2008 | Active | Administrateur | Bettws NP20 7DQ Newport Parret Road United Kingdom | Wales | British | ||
| CLEARWATER CARE (LEADON COURT) LIMITED | 03 oct. 2007 | Active | Administrateur | Parret Road Bettws NP20 7DQ Newport Millheath Nursing Home Gwent United Kingdom | Wales | British | ||
| CLEARWATER CARE (LEADON COURT) LIMITED | 03 oct. 2007 | Active | Secrétaire | Parret Road Bettws NP20 7DQ Newport Millheath Nursing Home Gwent United Kingdom | British | |||
| FC SUMMERHILL NH LTD | 14 févr. 2006 | Active | Administrateur | Parret Road NP20 7DQ Bettws C/O Millheath Nursing Home Newport United Kingdom | Wales | British | ||
| SUMMERHILL COMMUNITY CARE LTD | 01 janv. 2005 | Dissoute | Administrateur | 57 Harrowby Street CF10 5GA Cardiff | Wales | British | ||
| FC MILL HEATH LTD | 12 févr. 2003 | Active | Secrétaire | 57 Harrowby Street CF10 5GA Cardiff | British | |||
| KINGSTON APARTMENTS LTD | 15 mai 2002 | Active | Secrétaire | C/O Mill Heath Nursing Home Parret Road NP20 7DQ Newport | British | |||
| KINGSTON APARTMENTS LTD | 15 mai 2002 | Active | Administrateur | C/O Mill Heath Nursing Home Parret Road NP20 7DQ Newport | Wales | British | ||
| FC PANTEG LIMITED | 01 mars 2005 | 11 déc. 2020 | Active | Administrateur | 147 Hampstead Way NW11 7YA London 147 United Kingdom | Wales | British | |
| FC PANTEG LIMITED | 01 mars 2005 | 11 déc. 2020 | Active | Secrétaire | 57 Harrowby Street CF10 5GA Cardiff | British | ||
| FC PANTEG HOMECARE LTD | 20 mars 2003 | 19 déc. 2014 | Dissoute | Secrétaire | 57 Harrowby Street CF10 5GA Cardiff | British | ||
| FC PANTEG HOMECARE LTD | 20 mars 2003 | 19 déc. 2014 | Dissoute | Administrateur | 57 Harrowby Street CF10 5GA Cardiff | Wales | British | |
| DEEZEE LIMITED | 24 oct. 2003 | 01 févr. 2008 | Liquidation | Secrétaire | 7 Herons Way CF83 1SW Caerphilly | British | ||
| TOWY HAVEN CARE HOMES LIMITED | 08 sept. 2000 | 30 sept. 2006 | Active | Secrétaire | 7 Herons Way CF83 1SW Caerphilly | British | ||
| SWANTON CARE & COMMUNITY (MAESTEILO CARE HOMES) LIMITED | 10 mars 2000 | 08 mai 2006 | Active | Secrétaire | 29 Malpas Road NP20 5PB Newport | British | ||
| A PRINT & DESIGN LTD | 16 avr. 2003 | 24 nov. 2005 | Active | Secrétaire | 7 Herons Way CF83 1SW Caerphilly | British | ||
| CALMCARE CONSULTING LIMITED | 19 févr. 2001 | 25 juil. 2005 | Active | Secrétaire | 7 Herons Way CF83 1SW Caerphilly | British | ||
| TY-TEILO LIMITED | 12 févr. 2003 | 18 avr. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 7 Herons Way CF83 1SW Caerphilly | British | ||
| BLAENDYFFRYN CARE LTD | 18 déc. 2001 | 18 nov. 2004 | Dissoute | Secrétaire | 7 Herons Way CF83 1SW Caerphilly | British | ||
| BOGACKI PROJECT LTD | 14 nov. 2001 | 05 nov. 2004 | Dissoute | Secrétaire | 7 Herons Way CF83 1SW Caerphilly | British | ||
| PA PROMOTIONS LIMITED | 22 août 2002 | 15 août 2004 | Active | Secrétaire | 7 Herons Way CF83 1SW Caerphilly | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0