J & C BUSINESS (UK) CO., LTD
  • Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • J & C BUSINESS (UK) CO., LTD

    Dirigeant de société

    NomJ & C BUSINESS (UK) CO., LTD
    Est un dirigeant de sociétéOui
    Nominations
    Actif4
    Inactif417
    Démissionné665
    Total1086

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéRôleAdresse
    SKIN CARE RESEARCH CENTER LIMITED28 mai 201907 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    12020565 - Companies House Default Address
    BOYLEES SCIENCE LIMITED09 nov. 201807 mai 2024ActiveSecrétaire
    Brighton Road
    CR2 6EQ South Croydon
    291
    United Kingdom
    CHINA MEIYA GROUP LIMITED06 avr. 201707 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    10712088 - Companies House Default Address
    AECHOO TECHNOLOGY CO. LTD08 avr. 201607 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09576147 - Companies House Default Address
    MAXCONN MARINE SERVICE CO., LTD06 juil. 202106 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    12081895 - Companies House Default Address
    DALIAN YIZHOU SHIPPING PROCESSING LTD22 févr. 202106 mai 2024ActiveSecrétaire
    Brighton Road
    CR2 6EQ South Croydon
    291
    United Kingdom
    YIHAI MARINE SERVICE CO., LTD17 déc. 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    12367145 - Companies House Default Address
    MARINE CORROSION SERVICE LIMITED27 nov. 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    11704554 - Companies House Default Address
    FOREVER MARINE SERVICE CO., LTD13 nov. 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    11678377 - Companies House Default Address
    PLUGPLUS AUDIO LTD23 sept. 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    08723502 - Companies House Default Address
    JC METALLURGY SRL LTD23 sept. 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09259493 - Companies House Default Address
    SUM CARBON PVT LTD23 sept. 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09259717 - Companies House Default Address
    TIANYUE BIOCHEMICAL CO., LTD03 sept. 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    11527923 - Companies House Default Address
    UPWAY GLOBE CO., LTD28 août 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    12174515 - Companies House Default Address
    DEE GLOBE CO., LTD21 août 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    Brighton Road
    CR2 6EQ South Croydon
    291
    United Kingdom
    DEKLE CHEMICAL LTD.16 juil. 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    Brighton Road
    CR2 6EQ South Croydon
    291
    United Kingdom
    ROEMBECK LTD11 mai 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    10921497 - Companies House Default Address
    CAMBRIDGE CRADLE EDUCATION GROUP CO., LTD16 avr. 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    11160098 - Companies House Default Address
    RAPIDRABBIT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.18 mars 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09517699 - Companies House Default Address
    ND CHEMICALS CO., LTD12 mars 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    Brighton Road
    CR2 6EQ South Croydon
    291
    United Kingdom
    SUZHOU TONGDA MACHINERY CO., LTD.10 mars 202006 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    11862815 - Companies House Default Address
    GELLOWEN SCIENCE LIMITED19 déc. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    07491429 - Companies House Default Address
    SPAY GROUP CHINA IMPORT AND EXPORT LIMITED17 déc. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    Brighton Road
    CR2 6EQ South Croydon
    291
    United Kingdom
    XINGTAI KUNLUN MACHINERY CO., LTD09 déc. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    Brighton Road
    CR2 6EQ South Croydon
    291
    United Kingdom
    YINGKOU LIAOHE MACHINERY & PIPE FITTINGS CO., LTD.05 déc. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    11115128 - Companies House Default Address
    SISTERBEBE CHILDCARE COMPANY LIMITED25 nov. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09861256 - Companies House Default Address
    NINGBO AUTOP INDUSTRY CO., LTD14 nov. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    Brighton Road
    CR2 6EQ South Croydon
    291
    United Kingdom
    YUFENG CONSUMER PRODUCTS MANUFACTURING LTD24 oct. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    08751509 - Companies House Default Address
    GOODY INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED17 sept. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    06725592 - Companies House Default Address
    DIGGENS LIMITED11 sept. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    Brighton Road
    CR2 6EQ South Croydon
    291
    United Kingdom
    FIT PRECISION MOLD CO., LTD11 sept. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    06375365 - Companies House Default Address
    FADCOVER MERRYMODE APPAREL LTD10 sept. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    11006100 - Companies House Default Address
    SENSHANBOG LTD05 sept. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    Brighton Road
    CR2 6EQ South Croydon
    291
    United Kingdom
    GERMANY OUROHR PLASTIC INDUSTRY GROUP CO., LTD.26 juin 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    Brighton Road
    CR2 6EQ South Croydon
    291
    United Kingdom
    AUTOS INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.24 avr. 201906 mai 2024ActiveSecrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09600648 - Companies House Default Address

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0