EVERSECRETARY LIMITED
Dirigeant de société
Nom | EVERSECRETARY LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 8 |
Inactif | 203 |
Démissionné | 1404 |
Total | 1615 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
BABBLELABS2020 LIMITED | 18 déc. 2020 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House England | |
LDC VENTURES UK LIMITED | 20 sept. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
KONEXO GLOBAL LTD | 07 juin 2019 | Active | Secrétaire | New Bailey 6 Stanley Street M3 5GS Salford 2 Greater Manchester United Kingdom | |
JULY SYSTEMS (UK) LIMITED | 03 oct. 2018 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
BLOCKSTRA LIMITED | 03 oct. 2018 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
THE HEALTHY BOWELS COMPANY LIMITED | 15 août 2018 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
BIOKULT LIMITED | 15 août 2018 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
CAMBRIDGE BIOCEUTICALS LIMITED | 15 août 2018 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
FISKE FOOD LIMITED | 13 août 2018 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
ELLIS & EVERARD DISTRIBUTION LIMITED | 13 août 2018 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
ERICO EUROPA (G.B.) LIMITED | 05 juil. 2018 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
SHAYLOR MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 08 janv. 2018 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
SCHROFF UK LIMITED | 01 mars 2017 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
EDWARD BARBER (U.K.) LIMITED | 01 mars 2017 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
GOYEN CONTROLS CO UK LIMITED | 01 mars 2017 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
RAYCHEM HTS LIMITED | 01 mars 2017 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
EDWARD BARBER & COMPANY LIMITED | 01 mars 2017 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
NBTY INTL. LIMITED | 20 juin 2016 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
JASPER TECHNOLOGIES LIMITED | 09 mai 2016 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
CLIQR TECHNOLOGIES U.K. LIMITED | 15 avr. 2016 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
NBTY INTERNATIONAL (APAC) LIMITED | 04 mars 2016 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
RUMURUTI SOLAR GENERATION HOLDING LIMITED | 26 févr. 2016 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
ALBEMARLE CAMBRIDGE CHEMICALS LIMITED | 01 févr. 2016 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
ALBEMARLE AVONMOUTH WORKS LIMITED | 01 févr. 2016 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
ALBEMARLE MEDWAY UK LIMITED | 01 févr. 2016 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
ROCKWOOD LITHIUM (UK) LTD | 01 févr. 2016 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
PIA GETTY FILMS LIMITED | 27 janv. 2016 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
ACATOS LIMITED | 10 déc. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
ADM COCOA PROCESSING LIMITED | 10 déc. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
ADM WESSON PROPERTIES LIMITED | 10 déc. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
PURA FOODS GROUP LIMITED | 10 déc. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
PURA GROUP SEP TRUSTEE LIMITED | 10 déc. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
CHANCELOT MILL LIMITED | 10 déc. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
PURA THREE LIMITED | 10 déc. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom | |
ARCHER DANIELS MIDLAND INVESTMENTS (UK) LIMITED | 10 déc. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House United Kingdom |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0