DENISON TILL COMPANY SECRETARIES LIMITED
Dirigeant de société
Nom | DENISON TILL COMPANY SECRETARIES LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 30 |
Total | 33 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
DENCO 10 LIMITED | 22 août 2011 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly York Stamford House North Yorkshire United Kingdom | |
DENCO 9 LIMITED | 21 oct. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire England | |
DENCO 7 LIMITED | 22 avr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire England | |
COVERBALOO LIMITED | 01 déc. 2017 | 23 janv. 2020 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House United Kingdom |
CAVERE GROUP LIMITED | 11 sept. 2009 | 23 janv. 2020 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire United Kingdom |
CAVERE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 11 sept. 2009 | 23 janv. 2020 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire United Kingdom |
CAVERE LIMITED | 11 sept. 2009 | 23 janv. 2020 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire United Kingdom |
OXENBY PLACE MANAGEMENT CO LIMITED | 21 oct. 2014 | 20 juil. 2017 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire United Kingdom |
PARADE PROPERTY MANAGEMENT CO LIMITED | 21 oct. 2014 | 20 juil. 2017 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire United Kingdom |
NESSFIELD PLACE PROPERTY MANAGEMENT CO LIMITED | 07 mai 2013 | 26 avr. 2017 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House United Kingdom |
MULGRAVE HOMES LIMITED | 20 juin 2013 | 15 mai 2015 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House England |
THE NATIONAL NON-FOOD CROPS CENTRE LIMITED | 02 déc. 2011 | 21 oct. 2014 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House United Kingdom |
MP (PARADE) LIMITED | 18 oct. 2013 | 07 août 2014 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House United Kingdom |
EGERTON GARDENS LIMITED | 24 juin 2014 | 06 juil. 2014 | Dissoute | Administrateur | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House United Kingdom |
MOORLAND CLOSE PROPERTY MANAGEMENT CO LIMITED | 12 avr. 2012 | 07 nov. 2013 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire England |
MP (EASINGWOLD) LIMITED | 07 mars 2013 | 28 mars 2013 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House United Kingdom |
MULGRAVE DEVELOPMENTS LIMITED | 07 mars 2013 | 28 mars 2013 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House United Kingdom |
MP (NUNTHORPE) LIMITED | 13 déc. 2012 | 19 déc. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire United Kingdom |
PDF MATCH LTD | 12 déc. 2011 | 08 mai 2012 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House United Kingdom |
POTTERGATE MEWS MANAGEMENT COMPANY (NO. 2) LIMITED | 24 nov. 2010 | 04 avr. 2012 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire England |
HAROLD NEWSOME HOLDINGS LIMITED | 28 févr. 2012 | 06 mars 2012 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire |
WHITBY SCAMPI SHACK LIMITED | 23 sept. 2011 | 23 janv. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire United Kingdom |
MULGRAVE ESTATE LIMITED | 06 oct. 2011 | 19 nov. 2011 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire United Kingdom |
AGILITY MULTICHANNEL LIMITED | 11 oct. 2010 | 24 août 2011 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire England |
REPRESENTATION UK LIMITED | 22 avr. 2010 | 24 janv. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire |
MILL MOUNT MANAGEMENT LIMITED | 09 févr. 2010 | 01 déc. 2010 | Active | Administrateur | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire |
ENTERAL UK LIMITED | 13 avr. 2010 | 07 oct. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire |
THE BARKER PARTNERSHIP LIMITED | 07 janv. 2010 | 02 sept. 2010 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire |
THE BURTWISTLE PARTNERSHIP LIMITED | 06 mars 2010 | 02 sept. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire United Kingdom |
LES MAY SIGNALLING LIMITED | 15 avr. 2010 | 02 août 2010 | Dissoute | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire |
TESTING INSTALLATION CORRELATION SERVICES (GLOBAL) LIMITED | 22 févr. 2010 | 29 juil. 2010 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire |
KEITH RENNIE MACHINERY (HOLDINGS) LIMITED | 22 févr. 2010 | 21 juin 2010 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire |
UK THERMOS HOLDINGS LIMITED | 03 mars 2010 | 11 juin 2010 | Active | Secrétaire | Piccadilly YO1 9PP York Stamford House North Yorkshire |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0