Charles Malcolm MCINNES
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Charles |
Deuxième prénom | Malcolm |
Nom de famille | MCINNES |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 4 |
Démissionné | 50 |
Total | 55 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO2 LINCS CHP LIMITED | 21 juil. 2009 | Dissoute | Secrétaire | Oak Tree Court Mulberry Drive CF23 8RS Cardiff Gate Business Park Vision House Cardiff | British | |||
TIDAL ENERGY LIMITED | 20 déc. 2007 | Liquidation | Secrétaire | Brigantine Place CF10 4BY Cardiff Ground Floor, 16 Columbus Walk | British | |||
ECO2 CENTRAL LIMITED | 08 août 2007 | Dissoute | Secrétaire | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | British | |||
GLYNCORRWG RENEWABLE ENERGY LIMITED | 31 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | British | |||
FOCHRIW RENEWABLE ENERGY LIMITED | 23 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | British | |||
ECO2 RIOJA LIMITED | 26 janv. 2009 | 01 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Oak Tree Court Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House | British | ||
ECO2 MEDINA LIMITED | 26 janv. 2009 | 01 janv. 2018 | Dissoute | Secrétaire | Oak Tree Court Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House | British | ||
ECO2 ARANDA LIMITED | 26 janv. 2009 | 01 janv. 2018 | Dissoute | Secrétaire | Oak Tree Court Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House | British | ||
ECO2 BIOMASS LIMITED | 18 juil. 2007 | 01 janv. 2018 | Dissoute | Secrétaire | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | British | ||
ECO2 ESPANA LIMITED | 19 mars 2007 | 01 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | British | ||
ECO RENEWABLES LIMITED | 12 déc. 2006 | 01 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | British | ||
ECO2 MARINE ENERGY LIMITED | 16 janv. 2006 | 01 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Oak Tree Court Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House | British | ||
ECO2 LIMITED | 15 févr. 2005 | 01 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | British | ||
ECO2 ESPANA LIMITED | 23 déc. 2015 | 18 janv. 2017 | Active | Company Director | Administrateur | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | England | British |
ECO2 RIOJA LIMITED | 24 sept. 2015 | 18 janv. 2017 | Active | Company Director | Administrateur | Oak Tree Court Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House | England | British |
ECO2 MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 19 juin 2013 | 18 janv. 2017 | Active | Company Director | Administrateur | Oak Tree Court Mulberry Drive CF23 8RS Cardiff Gate Business Park Vision House Cardiff Wales | England | British |
ECO2 LIMITED | 20 oct. 2010 | 18 janv. 2017 | Active | Chartered Accountant | Administrateur | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | England | British |
PORT CLARENCE ENERGY LIMITED | 06 mai 2014 | 15 sept. 2015 | En administration | Company Secretary | Administrateur | c/o Clive Owen & Co Llp Coniscliffe Road DL3 7RT Darlington 140 County Durham England | England | British |
ECO2 DEVELOPMENTS LIMITED | 30 mars 2014 | 15 sept. 2015 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Oak Tree Court Mulberry Drive CF23 8RS Cardiff Gate Business Park Vision House Cardiff Wales | England | British |
AN DEVELOPMENT LIMITED | 11 juin 2007 | 11 juin 2015 | Active | Secrétaire | 20 Willoughby Close Alveston BS35 3RW Bristol | British | ||
MARGAM GREEN ENERGY LIMITED | 05 sept. 2013 | 22 janv. 2015 | Active | Company Director | Administrateur | Oak Tree Court, Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Wales | England | British |
ECO2 SOUTH WALES LIMITED | 16 juil. 2013 | 22 janv. 2015 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Oak Tree Court Mulberry Drive CF23 8RS Cardiff Gate Business Park Vision House Cardiff Wales | England | British |
BOGANLEA RENEWABLE ENERGY LIMITED | 30 août 2006 | 10 janv. 2014 | Active | Secrétaire | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | British | ||
BRIGG RENEWABLE POWER LIMITED | 08 août 2007 | 12 nov. 2013 | Active | Secrétaire | Bedford Row WC1R 4JS London 20-22 United Kingdom | British | ||
BRIGG RENEWABLE POWER FUELS LIMITED | 01 juin 2007 | 01 nov. 2013 | Active | Secrétaire | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | British | ||
ECO2 CENTRAL LIMITED | 28 sept. 2012 | 12 avr. 2013 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Mulberry Drive Cardiff Gate Business Park CF23 8RS Cardiff Vision House Oak Tree Court | England | British |
LINCOLNSHIRE BIOMASS LTD | 22 déc. 2006 | 09 déc. 2011 | Active | Secrétaire | 20 Willoughby Close Alveston BS35 3RW Bristol | British | ||
GREP1 LIMITED | 16 nov. 2006 | 09 déc. 2011 | Active | Secrétaire | 20 Willoughby Close Alveston BS35 3RW Bristol | British | ||
HATTON WINDPOWER LIMITED | 24 avr. 2008 | 07 oct. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 20 Willoughby Close Alveston BS35 3RW Bristol | British | ||
ECO2 HATTON LIMITED | 23 mai 2007 | 07 oct. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Willoughby Close Alveston BS35 3RW Bristol 20 England | British | ||
ECO2 CAMBRIAN LIMITED | 28 sept. 2005 | 02 juin 2010 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 20 Willoughby Close Alveston BS35 3RW Bristol | British | |
CAMBRIAN RENEWABLE ENERGY LIMITED | 28 févr. 2005 | 02 juin 2010 | Active | Secrétaire | 20 Willoughby Close Alveston BS35 3RW Bristol | British | ||
REDIMO LFG POWER LTD. | 30 sept. 2005 | 04 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 20 Willoughby Close Alveston BS35 3RW Bristol | British | ||
FRAMPTON POWER LIMITED | 30 sept. 2005 | 04 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 20 Willoughby Close Alveston BS35 3RW Bristol | British | ||
REDIMO LFG POWER LTD. | 28 sept. 2005 | 04 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 20 Willoughby Close Alveston BS35 3RW Bristol | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0