Paul Andrew Joseph KEEGAN
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Paul |
Deuxième prénom | Andrew Joseph |
Nom de famille | KEEGAN |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 2 |
Démissionné | 19 |
Total | 21 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAR 102 LIMITED | 07 août 2009 | Dissoute | Secrétaire | Aspley Park Drive NG8 3EG Aspley 79 Nottinghamshire | British | |||
PETER JACKS LIMITED | 02 juin 2008 | Dissoute | Practice Manager | Secrétaire | Aspley Park Drive NG8 3EG Aspley 79 Nottinghamshire | British | ||
ANZAR LIMITED | 02 juin 2008 | 26 févr. 2021 | Active | Practice Manager | Secrétaire | Pride Park DE24 8ZS Derby 1 Pinnacle Way Derbyshire United Kingdom | British | |
GAVIN WHITE LIMITED | 07 mai 2009 | 27 mars 2020 | Dissoute | Secrétaire | Friar Lane NG1 6ED Nottingham 84 | British | ||
RICHARD WOLLACOTT LIMITED | 06 mai 2009 | 27 mars 2020 | Dissoute | Secrétaire | Friar Lane NG1 6ED Nottingham 84 | British | ||
DONALD PEEL LIMITED | 18 juin 2008 | 27 mars 2020 | Dissoute | Secrétaire | Friar Lane NG1 6ED Nottingham 84 | British | ||
EDWARD CURSHAM LIMITED | 02 juin 2008 | 27 mars 2020 | Dissoute | Secrétaire | Friar Lane NG1 6ED Nottingham 84 | British | ||
PATRICK WOOD LIMITED | 02 juin 2008 | 27 mars 2020 | Dissoute | Secrétaire | Friar Lane NG1 6ED Nottingham 84 | British | ||
LUCAS LICENSING LIMITED | 02 juin 2008 | 30 juin 2019 | Active | Secrétaire | Pride Park DE24 8ZS Derby 1 Pinnacle Way Derbyshire United Kingdom | British | ||
GRAHAM M GREEN LIMITED | 02 juin 2008 | 20 févr. 2018 | Active | Secrétaire | Friar Lane NG1 6ED Nottingham 84 | British | ||
THORNWOOD LIMITED | 02 juin 2008 | 12 déc. 2017 | Dissoute | Secrétaire | Furniss Avenue S17 3QJ Sheffield 73 England | British | ||
ANDREW READY LIMITED | 02 juin 2008 | 14 janv. 2015 | Dissoute | Secrétaire | Friar Lane NG1 6ED Nottingham 84 | British | ||
ROBIN M WRIGHT LIMITED | 02 juin 2008 | 30 juin 2012 | Dissoute | Secrétaire | Far Street Wymeswold LE12 6TZ Loughborough 12 Leicestershire United Kingdom | British | ||
TONY PALFREMAN LIMITED | 02 juin 2008 | 30 juin 2012 | Dissoute | Secrétaire | Grandfield Avenue Radcliffe-On-Trent NG12 1AL Nottingham 6 United Kingdom | British | ||
TONY RUSSELL LIMITED | 02 juin 2008 | 02 juin 2012 | Dissoute | Secrétaire | Aspley Park Drive NG8 3EG Aspley 79 Nottinghamshire | British | ||
PRAMILA MEGHANI LIMITED | 02 juin 2008 | 02 juin 2011 | Dissoute | Secrétaire | Aspley Park Drive NG8 3EG Aspley 79 Nottinghamshire | British | ||
SHAREMYRIDE LIMITED | 07 août 2009 | 04 févr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Aspley Park Drive NG8 3EG Aspley 79 Nottinghamshire | British | ||
CITY REPAIR LIMITED | 07 août 2009 | 08 janv. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Aspley Park Drive NG8 3EG Aspley 79 Nottinghamshire | British | ||
LONDON FAST FOOD INVESTMENTS LIMITED | 07 août 2009 | 15 déc. 2009 | Active | Secrétaire | Aspley Park Drive NG8 3EG Aspley 79 Nottinghamshire | British | ||
CITY SHISHA LOUNGE LIMITED | 07 août 2009 | 09 déc. 2009 | Dissoute | Secrétaire | Aspley Park Drive NG8 3EG Aspley 79 Nottinghamshire | British | ||
TOTEM SOLUTIONS LIMITED | 07 août 2009 | 21 août 2009 | Dissoute | Secrétaire | Aspley Park Drive NG8 3EG Aspley 79 Nottinghamshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0