• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Alistair Graham NAPIER

    Personne physique

    TitreMr
    PrénomAlistair
    Deuxième prénomGraham
    Nom de familleNAPIER
    Date de naissance
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif1
    Inactif3
    Démissionné19
    Total23

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    BRAESTONE LIMITED20 oct. 2016LiquidationSolicitorAdministrateur
    DD1 1HN Dundee
    78-84 Bell Street
    Scotland
    ScotlandBritish
    HERONTRUSTEES LIMITED28 mars 2008DissouteDirectorAdministrateur
    48 Tay Street
    PH1 5TR Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish
    COMMERCIAL LEGAL CENTRE LLP16 nov. 2006DissouteMembre désigné de la LLP
    Tay Street
    PH1 5TR Perth
    36-38
    Perthshire
    Scotland
    GRASSICK'S PROPERTIES LIMITED15 mai 1996DissouteSecrétaire
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    British
    GLENAPPIN LIMITED16 nov. 201606 mai 2024ActiveSolicitorAdministrateur
    Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Taypark
    Perthshire
    ScotlandBritish
    PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE (HOLDINGS) LIMITED29 févr. 200003 déc. 2021ActiveSolicitorAdministrateur
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish
    PERTHSHIRE SOLICITORS PROPERTY CENTRE LIMITED29 févr. 200031 oct. 2021ActiveSolicitorAdministrateur
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish
    APPINDALE LIMITED12 mars 199821 sept. 2021ActiveWriter To The SignetAdministrateur
    George Street
    Floor 2
    EH2 2LR Edinburgh
    56
    Scotland
    ScotlandBritish
    GRASSICK'S GARAGE LIMITED01 janv. 199601 août 2017ActiveSecrétaire
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    British
    AIR SERVICE TRAINING (ENGINEERING) LIMITED13 mars 201217 août 2015En administrationSolicitorAdministrateur
    Tay Street
    PH1 5TR Perth
    36
    Scotland
    ScotlandBritish
    LAKESTREAM LIMITED12 mars 199815 juil. 2011ActiveWriter To The SignetAdministrateur
    Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    16
    ScotlandBritish
    ATHENA PARTNERSHIP LTD.12 mars 200901 févr. 2011DissouteSolicitorAdministrateur
    Young Street
    EH2 4JB Edinburgh
    16
    Lothian
    ScotlandBritish
    ATHENA ASSET MANAGEMENT LTD.29 mai 200814 janv. 2011DissouteSolicitorAdministrateur
    Tay Street
    PH1 5TR Perth
    36
    Perthshire
    Scotland
    ScotlandBritish
    GLENAPPIN LIMITED27 mars 2008ActiveSolicitorAdministrateur
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish
    OS ASSETS LIMITED24 févr. 199923 août 2007ActiveSolicitorSecrétaire
    48 Tay Street
    PH1 5TR Perth
    Perthshire
    British
    KIPPEN CAMPBELL W.S.17 mars 198820 juil. 2007ActiveSecrétaire
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    British
    KC PROPERTY RENTALS LTD.01 août 200201 mai 2004ActiveSolicitorAdministrateur
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish
    KIPPEN CAMPBELL (TRUSTEES) LIMITED25 févr. 199901 mai 2004ActiveWriter To The SignetAdministrateur
    48 Tay Street
    PH1 5TR Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish
    KC NOMINEES LIMITED09 juil. 199001 mai 2004ActiveWriter To The SignetAdministrateur
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish
    KIPPEN CAMPBELL NOMINEES LIMITED29 déc. 198901 mai 2004ActiveWriter To The SignetAdministrateur
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish
    KIPPEN CAMPBELL W.S.17 mars 198801 mai 2004ActiveSolicitorAdministrateur
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish
    THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (DUNDEE)11 déc. 200129 mars 2004ActiveSolicitorAdministrateur
    Taypark Isla Road
    PH2 7HQ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish
    KC PROPERTY RENTALS LTD.26 mai 199925 avr. 2000ActiveWriter To The SignetAdministrateur
    48 Tay Street
    PH1 5TR Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0